BLACKS LEISURE GROUP PLC

BLACKS LEISURE GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLACKS LEISURE GROUP PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00582190
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GREENFIELD BLACKS PLC26 ott 198426 ott 1984
    GREENFIELDS LEISURE P.L.C.31 dic 197931 dic 1979
    GREENFIELD MILLETTS LIMITED11 apr 195711 apr 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 feb 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 19 giu 2013

    20 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mag 2013

    21 pagine2.24B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    1 pagine2.17B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 nov 2012

    21 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    21 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 lug 2012

    21 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    30 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    1 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    93 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da , 440-450 Cob Drive, Swan Valley, Northampton, Northamptonshire, NN4 9BB, England in data 27 feb 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Marcello Lombardo come amministratore in data 16 dic 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Dominic Joseph Lavelle come amministratore in data 21 nov 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    25 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 set 2011

    Stato del capitale al 05 set 2011

    • Capitale: GBP 1,731,939.19
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 26 feb 2011

    83 pagineAA

    Cessazione della carica di Neil Gillis come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Peter Woodhouse Williams come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Bernstein come amministratore

    1 pagineTM01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 03 ago 2011

    • Capitale: GBP 1,731,939.19
    4 pagineSH06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share buy-back agreement 27/07/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Nomina di Ms Julia Reynolds come amministratore

    2 pagineAP01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 22 dic 2010

    5 pagine1.3

    Chi sono gli amministratori di BLACKS LEISURE GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BEACHAM, Mark Derrick
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Segretario
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    British135313320001
    HAMMERSLEY, Mark Andrew
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    EnglandBritish82090060002
    KNIGHT, Thomas William
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    EnglandBritish134562080001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    United KingdomBritish137285750001
    REYNOLDS, Julia
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    EnglandBritish127468460001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    Amministratore
    c/o Kpmg Llp
    M2 6DS Manchester
    St James Square
    EnglandBritish135547730001
    BENNETT, Terry
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    Segretario
    Randolph Avenue
    W9 1BG London
    72d
    British135196530001
    DAWSON, Mary Louise
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    Segretario
    57 Elms Road
    SW4 9EP London
    British68983920002
    HOLDSWORTH, Cheryl Irene
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    26 Chelveston
    AL7 2PW Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British48354260001
    O'KEEFFE, Mark John
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    Segretario
    5 Fowey Close
    NN8 5WW Wellingborough
    Northamptonshire
    British57880430001
    PILLAY, Paul Vijayasingam
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Segretario
    69 Lilleshall Avenue
    Monkston
    MK10 9HU Milton Keynes
    Other79416150001
    PLANT, William Allan
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    Segretario
    10 The Parks
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    County Durham
    British87465680001
    WILKINSON, John Richard
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    Segretario
    Abbey Cottage 1 Elm Lane
    Well End
    SL8 5PF Bourne End
    Buckinghamshire
    British2545190001
    BENNETT, Paul David
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Manor House
    Exelby
    DL8 2HB Bedale
    North Yorkshire
    British49486180001
    BENTLEY, Simon Anthony
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    Amministratore
    Glen Wood House
    5 Cedars Close
    NW4 1TR London
    United KingdomBritish3007630001
    BERNSTEIN, David Alan
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish87832960001
    BOYSON, Rhodes, Dr Sir
    71 Paines Lane
    HA5 3BX Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    71 Paines Lane
    HA5 3BX Pinner
    Middlesex
    British43410920002
    CROSLAND, Roy Nicholson
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    Amministratore
    35 Addison Avenue
    W11 4QS London
    British30882970002
    FLEMING, Keith
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Brookmead House
    The Warren, East Horsley
    KT24 5RH Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish112723440002
    GILLIS, Neil Duncan
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish69204500003
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish30306840002
    HARDY, Russell Stephen Mons
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Reddings
    Langley Road, Claverdon
    CV35 8P Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish45844210003
    HARTLEY, Peter Christopher
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    Amministratore
    17 Jacobean Lane
    Knowle
    B93 9LP Solihull
    United KingdomBritish96458190001
    KNIGHT, Thomas William
    6 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    6 Beechfield Road
    Gosforth
    NE3 4DR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British11423040005
    LESSER, Leslie Hugh
    17 Burlescome Road
    SS1 1PN Southend-On-Sea
    Essex
    Amministratore
    17 Burlescome Road
    SS1 1PN Southend-On-Sea
    Essex
    United KingdomBritish107546990001
    LITTNER, Claude Manuel
    Austell Gardens
    NW7 4NS London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Austell Gardens
    NW7 4NS London
    1
    United Kingdom
    EnglandBritish139534830001
    LOMBARDO, Marcello
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish135699240001
    MALLETT, Andrew Howard
    29 St James's Drive
    SW17 7RN London
    Amministratore
    29 St James's Drive
    SW17 7RN London
    British49181060002
    MAYWOOD, Terry Osborn
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Longston House
    School Lane Islip
    NN14 3LQ Kettering
    Northamptonshire
    British39631730004
    SAMUEL, Nicolas Michael
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    Amministratore
    Cob Drive
    Swan Valley
    NN4 9BB Northampton
    440-450
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish78875220003
    SHERLING, Clive Richard
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20007920003
    SMITH, David Andrew Gordon
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    5 Dann Place The Waterfront
    Wilford Village
    NG11 7FA Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish124619670001
    SPURLING, Anthony James
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Park Cottage 49 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2JA St Albans
    Hertfordshire
    British5224490001
    SPURLING, Darren James
    Main Road
    Woolsington
    NE13 8BL Newcastle-Upon-Tyne
    Riftswood
    Tyne And Wear
    England
    Amministratore
    Main Road
    Woolsington
    NE13 8BL Newcastle-Upon-Tyne
    Riftswood
    Tyne And Wear
    England
    United KingdomBritish136265790001
    TRANGMAR, Donald George
    Penny Royal Village Lane
    SL2 3UY Hedgerley
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Penny Royal Village Lane
    SL2 3UY Hedgerley
    Buckinghamshire
    British62397260002

    BLACKS LEISURE GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 nov 2009
    Consegnato il 06 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 dic 1999
    Consegnato il 14 dic 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities ( whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any other jurisdiction) of each obligor to the security trustee and the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Charge over credit balances
    Creato il 18 ago 1996
    Consegnato il 30 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £500,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 77489993 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 apr 1989
    Consegnato il 11 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balance
    Creato il 19 gen 1988
    Consegnato il 26 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a guarantee dated 8/9/87 to the holders from time to time of £7,350,000 unsecured loan stock issued by blacks leisure group PLC on 8/9/87 & repayable on 2/5/88 covering repayment in consequence of default by the company in performance of its obligations
    Brevi particolari
    The sum of £5,000,000 together with interest accrued to be held by the bank on an account no. 6087124 & earmarker or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (See doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Wimpole Trustees Limited.
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 21 ago 1986
    Consegnato il 08 set 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1986Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 1985
    Consegnato il 21 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Directions
    Creato il 29 ago 1985
    Consegnato il 02 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1) all proceeds which ravensbourne registration services limited recieves of the rights issue which greenfield blacks PLC proposes to make. 2. all moneys which arbuthnot latham bank limited ("al") shal be obliged to pay on account for to greenfield blacks PLC under the underwriting agreement dated 29/8/85 3. all moneys of which al procures payment pursuant to the above underwriting agreement.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1985
    Consegnato il 30 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    54, high street, brentwood, essex t/no - ex 298598.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1985
    Consegnato il 30 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining 54, high street, brentwood, essex. T/no - ex 303601.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1985
    Consegnato il 30 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    281-287 high street, l/b of hounslow t/no- ngl 519537.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1985
    Consegnato il 09 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    137 and 137A high street waltham cross broxbourne.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 ago 1984
    Consegnato il 21 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 12 giu 1984
    Consegnato il 02 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    428 biggin st. Dover, kent. T/n k 455505.
    Persone aventi diritto
    • Municipal Mutual Insurance Limited.
    Transazioni
    • 02 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1984
    Consegnato il 14 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 42, biggin street, dover, kent. Title no. K 455505.
    Persone aventi diritto
    • Knowsley and Company
    Transazioni
    • 14 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 06 set 1983
    Consegnato il 09 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H interest in shop on the ground floor of 445 oxford street, london W1 and the first floors of 445/443 oxford street aforesaid.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 10 set 1982
    Consegnato il 16 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold the ground floor of 445 & the first floor of 443 & 445 oxford street, london W1.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fleming & Co. Limited.
    Transazioni
    • 16 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 set 1982
    Consegnato il 14 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Shop on the ground floor of 445 and the first floor of 443/445 oxford street, london W1.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    & supplemental charge further charge
    Creato il 25 feb 1982
    Consegnato il 04 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £660,000 and/or further securing all monies owing under a legal charge dated 29TH sept. 1977.
    Brevi particolari
    279/287, high street, hounslow. Title nos. Mx 505251, 7X 32253, mx 319394 & mx 319482. 137/139A high street, waltham cross. Title no. Hd 28115.
    Persone aventi diritto
    • Hambro Provident Assurance Limited
    Transazioni
    • 04 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 23 giu 1980
    Consegnato il 08 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge l/hold 155/157.89, 443 & 445 oxford street london W1. Title nos: ngl 215427 ln 248254 undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital stocks & shares.
    Persone aventi diritto
    • Robert Fleming & Co. Limited
    Transazioni
    • 08 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 28 mag 1980
    Consegnato il 05 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold lands and premises being ground floor cumberland hotel, oxford street london W1 with all fixtures present and future. Title no. Ngl 244761.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 giu 1972
    Consegnato il 21 giu 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £200,000.
    Brevi particolari
    443/445 oxford street london W.1.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 ott 1962
    Consegnato il 29 ott 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15000
    Brevi particolari
    54 watling avenue, burnt oak, edgware middlesex with all fixtures, present & future.
    Persone aventi diritto
    • Legal and General Assurance Society LTD
    Transazioni
    • 29 ott 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 25 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BLACKS LEISURE GROUP PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 nov 2009Data della riunione per approvare il CVA
    22 dic 2010Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    09 gen 2012Inizio dell'amministrazione
    19 giu 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0