S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED

S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàS.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00582544
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    295 Hoxton Street
    N1 5JX London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 feb 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 26 feb 2019

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2020

    6 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor, Woodgate Studios 2 -8 Games Road Barnet EN4 9HN England a 295 Hoxton Street London N1 5JX in data 14 ott 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Glen Anthony Charles il 18 ott 2018

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 58 Acacia Road Acacia Road London NW8 6AG a 1st Floor, Woodgate Studios 2 -8 Games Road Barnet EN4 9HN in data 19 ott 2018

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2017

    7 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 gen 2018 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 29 feb 2016

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 005825440012 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 005825440013 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    8 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CHARLES, Glen Anthony
    Hoxton Street
    N1 5JX London
    295
    England
    Amministratore
    Hoxton Street
    N1 5JX London
    295
    England
    EnglandBritishCompany Director63507650009
    ALEXANDER, Nigel Michael
    Bucks Close, Village Road
    Bromham
    MK43 8HG Bedford
    2
    England
    Segretario
    Bucks Close, Village Road
    Bromham
    MK43 8HG Bedford
    2
    England
    162208440001
    CHARLES, Samantha
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    152504630001
    SMITH, Betty Patricia
    9 Colwall Gardens
    The Crew
    IG8 0HS Woodford Green
    Essex
    Segretario
    9 Colwall Gardens
    The Crew
    IG8 0HS Woodford Green
    Essex
    British50775100001
    SMITH, Kathleen
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    British28112240001
    SMITH, Maria Elvira
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    BritishSecretary133068120001
    ALEXANDER, Nigel Michael
    Bucks Close, Village Road
    Bromham
    MK43 8HG Bedford
    2
    England
    Amministratore
    Bucks Close, Village Road
    Bromham
    MK43 8HG Bedford
    2
    England
    EnglandBritishDirector162208010001
    ANDERSON, Matthew James Robert
    Alexandra Drive
    KT5 9AF Surbiton
    56
    Surrey
    England
    Amministratore
    Alexandra Drive
    KT5 9AF Surbiton
    56
    Surrey
    England
    EnglandEnglishDirector117920400001
    CHARLES, Glen Anthony
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Developer63507650006
    POPE, Henry Thomas
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    BritishDirector28112250001
    SMITH, Kathleen
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    67 Whitehall Lane
    IG9 5JG Buckhurst Hill
    Essex
    BritishRetired28112240001
    SMITH, Stephen Russell
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor Woodgate Studios
    2-8 Games Road
    EN4 9HN Barnet
    1st
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector126684550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Acacia Road
    NW8 6AG London
    58
    England
    06 apr 2016
    Acacia Road
    NW8 6AG London
    58
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07383916
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    S.SMITH & CO.(DOWNHAM ROAD)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 feb 2014
    Consegnato il 13 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1 by way of legal mortgage all freehold and leasehold property now vested in the company together with al buildings, fixtures and fixed plant and machinery from time to time on that property.. 2 by way of fixed charge all estates or interests in any freehold and leasehold property of the company (not being property charged by 1 above) now and in the future vested in the company together with all buildings, fixtures and fixed plant and machinery from time to time on that property.. 3 by way of fixed charge all intellectual property rights choses in action and claims now and in the future belonging to the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 13 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 feb 2014
    Consegnato il 13 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All that freehold property situate and known as 26 orsman road, london N1 5QJ registered at hm land registry with title absolute under title number 458635.. notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 13 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 2012
    Consegnato il 14 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property comprised in land registry t/no. 458635.
    Persone aventi diritto
    • One Housing Group Limited
    Transazioni
    • 14 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over credit balance
    Creato il 12 lug 2012
    Consegnato il 20 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The security account and the account balance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over building contract
    Creato il 03 lug 2012
    Consegnato il 05 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge with full title guarantee all of its present and future rights title and interest in and to the contract see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security assignment
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 12 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the agreements. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 12 ago 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Dowgate wharf 26 orsman road hoxton hackney t/no 458635; all fixtures, fittings, fixed plant and machinery and equipment, proceeds of sale, by way of floating security all property and assets of whatsoever nature, assigns every insurance policy, benefit of all guarantees, warranties. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 12 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 giu 2010
    Consegnato il 24 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 24 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 16 giu 2010
    Consegnato il 19 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from city & suburban homes limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 26 orsman road, london t/no 458635 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Acceptances Limited
    Transazioni
    • 19 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1988
    Consegnato il 16 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Dowgate wharf 26 orsman road hoxton london borough of hackney title no:- 458635.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 1972
    Consegnato il 24 lug 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    26 orsman rd islington N1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 24 lug 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Inst of charge
    Creato il 04 ago 1965
    Consegnato il 13 ago 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    105 habley st hackney london E9.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 13 ago 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 30 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0