PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED

PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00584372
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED?

    • Altre lavorazioni e conservazioni di frutta e verdura (10390) / Industrie manifatturiere
    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit Bt95-4 Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2016

    3 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ott 2015

    Stato del capitale al 12 ott 2015

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2014 al 30 giu 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ott 2014

    Stato del capitale al 14 ott 2014

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Nigel Patrick Hebron come amministratore in data 31 ago 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Hebron come segretario in data 31 ago 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Giles Alexander Glidden Henderson come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Christopher Thorpe come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Nicholas Robert Bunker come amministratore in data 31 ago 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Robinson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian Lavery come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 ott 2013

    Stato del capitale al 17 ott 2013

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUNKER, Nicholas Robert
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    United KingdomBritishChief Executive Officer129281570003
    HENDERSON, Giles Alexander Glidden
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    EnglandBritishFinance Director175409820001
    THORPE, Mark Christopher
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    EnglandBritishM.D. Operations177004550001
    DALTON, Cecil
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    Segretario
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    British18738900001
    GIBBS, Gerald Alexander
    32 The Hythe
    CM9 5HN Maldon
    Essex
    Segretario
    32 The Hythe
    CM9 5HN Maldon
    Essex
    British17080600002
    HEBRON, Nigel
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Segretario
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    178313960001
    COCHRANE, Bruce
    Somerville
    Shay Lane, Halebarns
    WA15 8UD Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Somerville
    Shay Lane, Halebarns
    WA15 8UD Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Secretary84110450001
    CROSS, David Philip
    129 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 1HE London
    Amministratore
    129 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 1HE London
    United KingdomBritishDirector31520420001
    CROSS, David Philip
    129 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 1HE London
    Amministratore
    129 Green Dragon Lane
    Winchmore Hill
    N21 1HE London
    United KingdomBritishDirector - Sales Marketing31520420001
    DALTON, Cecil
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    Amministratore
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    BritishDirector18738900001
    DALTON, Lisa Abigail
    1 Bevan Street
    Islington
    N1 7DY London
    Amministratore
    1 Bevan Street
    Islington
    N1 7DY London
    EnglandBritishPurchasing Director60616190001
    DALTON, Michael John
    25 Nutter Lane
    Wanstead
    E11 2HZ London
    Amministratore
    25 Nutter Lane
    Wanstead
    E11 2HZ London
    United KingdomBritishChairman/Managing Director18738940001
    DAY, William Henry
    The Coach House
    Woodcroft Mottingham Lane Mottingham
    SE9 4RT London
    Amministratore
    The Coach House
    Woodcroft Mottingham Lane Mottingham
    SE9 4RT London
    BritishCompany Director41681080001
    GIBBS, Gerald Alexander
    32 The Hythe
    CM9 5HN Maldon
    Essex
    Amministratore
    32 The Hythe
    CM9 5HN Maldon
    Essex
    EngalndBritishFinance Director17080600002
    HEBRON, Nigel Patrick
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    EnglandBritishAccountant71676680002
    JACK, Robert Leslie
    Vicarage Hill
    Chelston
    TQ2 6HZ Torquay
    22
    Devon
    Amministratore
    Vicarage Hill
    Chelston
    TQ2 6HZ Torquay
    22
    Devon
    EnglandBritishDirector160735770001
    LAVERY, Ian
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    EnglandBritishOperations Director149907970001
    ROBINSON, Richard Anthony
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    Amministratore
    Tanfield Lea Industrial Estate
    DH9 9XS Stanley
    Unit Bt95-4
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director161051380001
    RYDER, Calum
    Oaklands
    NE3 4YQ Newcastle Upon Tyne
    25
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Oaklands
    NE3 4YQ Newcastle Upon Tyne
    25
    Tyne And Wear
    UkBritishDirector139348520001
    TURL, Peter Munro
    48 Parker Close
    SG6 3RT Letchworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    48 Parker Close
    SG6 3RT Letchworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director53530650001
    WEATHERHEAD, Michael John
    62 Church Road
    Low Fell
    NE9 5RJ Gateshead
    Tyne & Wear
    Amministratore
    62 Church Road
    Low Fell
    NE9 5RJ Gateshead
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector127902340001
    WILSON, Lewis Henry
    2 Martingale Close
    CM11 1SQ Billericay
    Essex
    Amministratore
    2 Martingale Close
    CM11 1SQ Billericay
    Essex
    BritishAccountant18738910001

    PERCY DALTON'S FAMOUS PEANUT COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal assignment
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 09 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 lug 2010
    Consegnato il 14 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on non-vesting debts and floating charge
    Creato il 11 giu 2010
    Consegnato il 15 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all debts and all export debts purportedly assigned to the security holder pursuant to the debt purchase agreement. All associated rights relating to any non-vesting domestic debts and non-vesting export debts. By way of first fixed charge the excluded proceeds and by way of first floating charge all present and future assets undertaking and all other property and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 15 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Book debts and accounts charge
    Creato il 01 mar 2005
    Consegnato il 09 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all its right, title and interest in and to the blocked accounts and to the french accounts and its UK book debts, both uncollected and collected. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 09 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of equipment
    Creato il 26 lug 2000
    Consegnato il 31 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee
    Brevi particolari
    All of the equipment; and all spare parts and replacements for and all modifications and additions to the equipment.title guarantee every disposition effected by the deed was made with full title guarantee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 31 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture,which is supplemental to a debenture dated 15 may 1997
    Creato il 01 ott 1999
    Consegnato il 15 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over the new plant. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 30 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the financing agreements
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Acceptances Limited
    Transazioni
    • 30 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement and charge
    Creato il 15 mag 1997
    Consegnato il 30 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the facility and financing agreements
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee by the agreement assigns to burdale all its rights,title,interest and benefit in those accounts receivable which are or become freely assignable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Acceptances Limited
    Transazioni
    • 30 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 feb 1996
    Consegnato il 21 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £65,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Brevi particolari
    1 x greasby quality management system serial nos. 3295.60. 1 x bulk vibratory feeder & inclined conveyor serial nos MH1202 vpe MH1202 fbe. 1 x flighted belt elevator & vibratory prefeeder serial nos. MH1195 fbe MH1195 vpf.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 08 apr 1994
    Consegnato il 13 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from percy dalton (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments and investments. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 13 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 mar 1994
    Consegnato il 14 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 feb 1994
    Consegnato il 18 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 giu 1990
    Consegnato il 13 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 apr 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 11 lug 1985
    Consegnato il 17 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing on incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Chattels mortgage.
    Creato il 27 ott 1982
    Consegnato il 28 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One-quinset (5 units) type WP36 weighing machine together with ancillary equipment. Serial no: M118.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited.
    Transazioni
    • 28 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 14 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0