LOCKEY BROS. LIMITED

LOCKEY BROS. LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOCKEY BROS. LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00587561
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOCKEY BROS. LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LOCKEY BROS. LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ey
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOCKEY BROS. LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LOCKEY BROS. LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Jayne Mary Worden come amministratore in data 11 dic 2019

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 gen 2019

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O 3rd Floor, Radley Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW a C/O Ey 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 feb 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 gen 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Gregory Pratt come segretario in data 03 giu 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Roger Clive Best come amministratore in data 03 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 feb 2016

    Stato del capitale al 04 feb 2016

    • Capitale: GBP 7,973
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Justin Paul David Stead come amministratore in data 07 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Xavier Marie Olivier Simonet come amministratore in data 08 mag 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2014

    AA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 gen 2015

    Stato del capitale al 22 gen 2015

    • Capitale: GBP 7,973
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O 6Th Floor, Radley + Co Greater London House Mornington Crescent Hampstead Road London NW1 7QX a Mcbeath House 310 Goswell Road London EC1V 7LW in data 30 lug 2014

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 feb 2014

    Stato del capitale al 05 feb 2014

    • Capitale: GBP 7,973
    SH01

    Nomina di Mrs Jayne Mary Worden come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Xavier Marie Olivier Simonet come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Pelham Allen come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LOCKEY BROS. LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STEAD, Justin Paul David
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    Amministratore
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    EnglandAmerican204126530001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Segretario
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    British67243220003
    BURROWS, Simon Glyn
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    Segretario
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    British151991020001
    MURPHY, Justin Robert Anthony
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    22 Harvey Road
    Croxley Green
    WD3 3BW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Australian71552870002
    MYERS, Philip Joseph
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    Segretario
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    British4749710002
    PRATT, Gregory
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Segretario
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    167195420001
    ALLEN, Pelham Brian
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o 6th Floor, Radley + Co
    Mornington Crescent
    Hampstead Road
    NW1 7QX London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritish166398180001
    BEST, Roger Clive
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandBritish114728210001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Amministratore
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Amministratore
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish67243220004
    BURROWS, Simon Glyn
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    Amministratore
    16 High Street
    Kimpton
    SG4 8RJ Hitchin
    Herts
    United KingdomBritish151991020001
    BURROWS, Victor George Charles
    3 Jennings Wood (Off Turpins Ride)
    AL6 Welwyn
    Herts
    Amministratore
    3 Jennings Wood (Off Turpins Ride)
    AL6 Welwyn
    Herts
    British33024950001
    DAVIES, Joyce
    121 Blythway
    Haldens
    AL7 1DL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    121 Blythway
    Haldens
    AL7 1DL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British82051110001
    ENEVOLDSON, Karl Thyge
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    Amministratore
    25 Orbital Crescent
    WD25 0HB Garston
    Hertfordshire
    British87906250001
    GAEDE, Sven Willi Swithin
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    Amministratore
    Greater London House
    Mornington Crescent
    NW1 7QX London
    EnglandBritish122640470001
    HARDER, Lowell Judith
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    Amministratore
    101 Englefield Road
    N1 3LJ London
    UkAustralian26244220001
    HOWELL, Christopher Rodney
    56 Kinloch Drive
    NW9 7LH London
    Amministratore
    56 Kinloch Drive
    NW9 7LH London
    British16548940001
    LOCKEY, Eric Bertram
    310 Knightsfield
    AL8 7NQ Welwyn Garden City
    Herts
    Amministratore
    310 Knightsfield
    AL8 7NQ Welwyn Garden City
    Herts
    British33024960001
    LOCKEY, Peter
    9 New Road
    Digswell
    AL6 0AE Welwyn
    Herts
    Amministratore
    9 New Road
    Digswell
    AL6 0AE Welwyn
    Herts
    EnglandBritish33024970001
    LOCKEY, Timothy
    40 The Green
    Stotfold
    SG5 4DG Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    40 The Green
    Stotfold
    SG5 4DG Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish92810850001
    MYERS, Philip Joseph
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    Amministratore
    Alderstead Farmhouse
    Alderstead Lane
    RH1 3AF Merstham
    Surrey
    British4749710002
    RODRIGUES, Selwyn Mario Pius
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    Amministratore
    224 Ferme Park Mansions
    Ferme Park Road
    N8 9BN London
    British78514760004
    SIMONET, Xavier Marie Olivier
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    Amministratore
    c/o 3rd Floor, Radley
    310 Goswell Road
    EC1V 7LW London
    Mcbeath House
    England
    EnglandFrench184753700001
    WARNER, Alan Mark
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    Amministratore
    38 Pattison Road
    NW2 2HJ London
    United KingdomBritish119324870001
    WORDEN, Jayne Mary
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    Amministratore
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    C/O Ey
    United KingdomBritish109333140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LOCKEY BROS. LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    06 apr 2016
    Goswell Road
    EC1V 7LW London
    310
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2573819
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    LOCKEY BROS. LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 12 lug 2006
    Consegnato il 01 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 28 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alan Mark Warner, Malcolm Warner, Christopher Howell and Peter Myers
    Transazioni
    • 28 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 feb 2003
    Consegnato il 28 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lowell Judith Harder
    Transazioni
    • 28 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 feb 1995
    Consegnato il 20 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 1993
    Consegnato il 04 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 04 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 set 1992
    Consegnato il 08 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 28, the observatory, high street, slough, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1992
    Consegnato il 13 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 28, the observatory, high street, slough, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 27 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 39, the grafton centre, cambridge, cambridgeshire. Title no. Cb 67180.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 21 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    92, queensway stevenage, hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 21 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45, howardsgate, welwyn garden city, hertfordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 20 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LOCKEY BROS. LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2018Inizio della liquidazione
    12 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joseph Luke Carleton
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praticante
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praticante
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0