ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED

ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00591419
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Stable Street
    N1C 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARGENT GROUP DEVELOPMENTS PLC20 apr 199420 apr 1994
    ARGENT HOLDINGS PLC18 apr 198418 apr 1984
    COUNTY COMMERCIAL INVESTMENTS LIMITED03 ott 195703 ott 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al14 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Ms Emily Clare Bird come amministratore in data 31 dic 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Bernard Lightbound come amministratore in data 31 dic 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Vijyanti Gorasia come amministratore in data 31 mag 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kirsty Ann-Marie Wilman come amministratore in data 31 mag 2024

    1 pagineTM01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 4 Stable Street London N1C 4AB

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 4 Stable Street London N1C 4AB

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di James Garwood Michael Wates come amministratore in data 01 mag 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Hugo Eccles Thompson come amministratore in data 01 mag 2024

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2023

    9 pagineAA

    Nomina di Joanne Elizabeth Massey come segretario in data 12 mar 2024

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Scudder come segretario in data 12 mar 2024

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2022

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di David Scudder come segretario in data 05 mar 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Anita Joanne Sadler come segretario in data 05 mar 2021

    1 pagineTM02

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Anita Joanne Sadler il 23 mag 2019

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2020

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Ms Kirsty Ann-Marie Wilman come amministratore in data 04 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jennifer Anne Lisbey come amministratore in data 04 feb 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Segretario
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    320428940001
    BIRD, Emily Clare
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    6th Floor, 150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    6th Floor, 150
    England
    United KingdomBritishProperty Fund Manager255271160001
    GORASIA, Vijyanti
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishReal Estate Fund Management295855170001
    TAYLOR, Christopher Mark
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    EnglandBritishCeo159396060001
    FREEMAN, Peter Geoffrey
    Airlie Lodge 64 Sheffield Terrace
    W8 7AP London
    Segretario
    Airlie Lodge 64 Sheffield Terrace
    W8 7AP London
    British11621550012
    MILLAR, Ronald
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    Segretario
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    British70586450001
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    Segretario
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    BritishCompany Director45043490002
    SADLER, Anita Joanne
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Segretario
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    BritishSolicitor104279900001
    SCUDDER, David
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Segretario
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    280498820001
    FREEMAN, Michael Ian
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector2119280002
    FREEMAN, Peter Geoffrey
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director11621550012
    GIDDINGS, Anthony Jan
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old Alms House
    Cage End Hatfield Broad Oak
    CM22 7HW Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director56956610003
    HAZELL, Peter Frank
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector76176480001
    LAURENCE, Robert
    29 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    Amministratore
    29 Saint Johns Avenue
    SW15 6AL London
    BritishCompany Director84494070001
    LIGHTBOUND, Michael Bernard
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United KingdomBritishDirector172186960003
    LISBEY, Jennifer Anne
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United KingdomBritishChartered Accountant259968930001
    MADELIN, Roger Nigel
    Spring Grove Road
    TW10 6EH Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Spring Grove Road
    TW10 6EH Richmond
    6
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director11621570009
    MILLAR, Ronald
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    49 Guthrie Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SD Auchterarder
    Perthshire
    BritishAccountant70586450001
    PARTRIDGE, David John Gratiaen
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United KingdomBritishDirector41215410027
    PARTRIDGE, David John Gratiaen
    39-41 All Saints Road
    Notting Hill
    W11 1HE London
    Flat 4
    United Kingdom
    Amministratore
    39-41 All Saints Road
    Notting Hill
    W11 1HE London
    Flat 4
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director41215410019
    PROWER, Aubyn James Sugden
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Marchants
    Lower Station Road Newick
    BN8 4HT Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director45043490002
    THOMPSON, Jonathan Hugo Eccles
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant175269020001
    WATES, James Garwood Michael, Sir
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Station Approach
    KT22 7SW Leatherhead
    Wates House
    Surrey
    England
    EnglandEnglishChairman43991900002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    Amministratore
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Argent Group Limited
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    England
    06 apr 2016
    Stable Street
    N1C 4AB London
    4
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleEngland & Wales Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales Companies Registry
    Numero di registrazione2187385
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ARGENT GROUP DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental mortgage of shares
    Creato il 06 set 2000
    Consegnato il 22 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilies whether actual or contingent due or to become due from argent development consortium limited and each investor to each finance party and to the counterparty under each finance document(all as defined therein)
    Brevi particolari
    The shares and all dividends stocks shares securities rights or property and intererest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft ("the Agent")
    Transazioni
    • 22 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental mortgage of shares
    Creato il 06 set 2000
    Consegnato il 22 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilies whether actual or contingent due or to become due from argent development consortium limited and each investor to each finance party and to the counterparty under each finance document(all as defined therein)
    Brevi particolari
    The shares and all dividends stocks shares securities rights or property and interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft ("the Agent")
    Transazioni
    • 22 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of shares
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 23 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent due or to become due from argent development consortium limited and each investor to the chargee under each finance document (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    The shares and all dividends stocks shares securities rights or property and interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Defined) and the Counterparty (As Defined)as Agent and Trustee for the Finance Parties (As
    Transazioni
    • 23 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of shares
    Creato il 05 gen 1996
    Consegnato il 05 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from argent development consortium limited and each investor to the chargee under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    101,000 ordinary shares of £1 each in argent development consortium limited and all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties and the Counterparty
    Transazioni
    • 05 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture and guarantee
    Creato il 23 apr 1993
    Consegnato il 29 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deed (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Benson Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture & guarantee
    Creato il 29 giu 1988
    Consegnato il 18 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the relevant obligations/as that term is defined in the charge)
    Brevi particolari
    The undertaking and all it property assets and rights etc., (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Bennon Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture and guarantee
    Creato il 17 feb 1988
    Consegnato il 03 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over undertaking and all property and rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort Bennon Limited
    Transazioni
    • 03 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0