WOODCHESTER FINANCE LIMITED

WOODCHESTER FINANCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOODCHESTER FINANCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00594155
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NENE INVESTMENTS LIMITED22 nov 195722 nov 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Kalpna Shah come segretario in data 31 gen 2018

    2 pagineTM02

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY United Kingdom a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 17 lug 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 giu 2017

    LRESSP

    Cessazione della carica di Lori Elizabeth Mochan come amministratore in data 27 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 01 mar 2017

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Paul Stewart Girling come amministratore in data 23 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gillian May Wheeler come amministratore in data 23 feb 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 4 Hatters Lane Croxley Green Business Park Watford Hertfordshire WD18 8YF a PO Box 2497 Building 4 Hatters Lane Watford WD18 1YY in data 11 ago 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Daphna Rachel Jowell come amministratore in data 08 lug 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GIRLING, Paul Stewart
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritish225432580001
    CRICHTON, Susan Elizabeth
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    Segretario
    The Pheasantries
    Ley Hill
    HP5 3QR Chesham
    Buckinghamshire
    British69358970001
    DRAZIN, Shirley
    4 St Lawrence Close
    HA8 6RB Edgware
    Middlesex
    Segretario
    4 St Lawrence Close
    HA8 6RB Edgware
    Middlesex
    British2457320001
    GREEN, Peter Harvey
    7 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    Segretario
    7 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    British123086060001
    GREGORY, Janet Ailsa
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Segretario
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British54836580002
    HAYES, Daniel Edward Laurence
    Alpine Cottage 6 Old Brandon Lane
    Shadwell
    LS17 8HP Leeds
    Yorkshire
    Segretario
    Alpine Cottage 6 Old Brandon Lane
    Shadwell
    LS17 8HP Leeds
    Yorkshire
    British78253650001
    HOPE, Neil Christopher
    45 Skaterigg Drive
    Jordanhill
    G13 1SR Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    45 Skaterigg Drive
    Jordanhill
    G13 1SR Glasgow
    Lanarkshire
    British64761380001
    OWENS, Jennifer Anne
    Flat A
    55 Agate Road
    W6 0AL London
    Segretario
    Flat A
    55 Agate Road
    W6 0AL London
    British113688770001
    RYAN, Gerard Jude
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    Segretario
    47 Kingsmead Road
    Tulse Hill
    SW2 3HY London
    Irish32962580001
    SHAH, Kalpna
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Segretario
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    199403680001
    FN SECRETARY LIMITED
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    136016010001
    BARKER, John Ian
    1 Codrington Court
    243 Rotherhithe Street
    SE16 1FT London
    Amministratore
    1 Codrington Court
    243 Rotherhithe Street
    SE16 1FT London
    British62310010002
    BARR, Ciaran Joseph, Mr.
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    IrelandIrish240977080001
    BERRY, Duncan Gee
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107695600022
    BRAMHALL, John Robert
    11 Stoke Hill
    Stoke Bishop
    BS9 1JL Bristol
    Amministratore
    11 Stoke Hill
    Stoke Bishop
    BS9 1JL Bristol
    British1020270002
    BRENNAN, Ann Elizabeth
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137519160001
    BRUNYATE, John Maitland
    Winter Lodge 95 Middlemead
    Hook
    Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Winter Lodge 95 Middlemead
    Hook
    Basingstoke
    Hampshire
    British72740940001
    BUICK, Craig Anthony
    3 Durkar Court
    WF4 3QR Durkar
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Durkar Court
    WF4 3QR Durkar
    West Yorkshire
    Australian99910330001
    BULLOCH, Robert James Mackenzie
    The Toll House Watergate
    Cleish
    KY13 0LS Kinross
    Fife
    Amministratore
    The Toll House Watergate
    Cleish
    KY13 0LS Kinross
    Fife
    British65105210001
    CAKEBREAD, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United KingdomBritish183172770001
    CAMERON, Ewan Douglas
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    Amministratore
    13 Heathfield Gardens
    W4 4JU London
    British122900270001
    CHESTERFIELD, Benjamin
    5 Frognal Close
    NW3 6YB London
    Amministratore
    5 Frognal Close
    NW3 6YB London
    United KingdomBritish67381990001
    DE RIDDER, Kimon Celicourt Macris, Dr
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131081660001
    DEVINE, Brendan
    15 Stoneleigh Avenue
    Shadwell Lane
    LS17 8FF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Stoneleigh Avenue
    Shadwell Lane
    LS17 8FF Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish113265830001
    DODDRELL, Paul Derek
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    IrelandBritish166226140001
    EVANS, Kellie Victoria
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish167417000001
    FERGUSON, Ian George
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish133318850001
    FLYNN, William John
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British99330320002
    GARDEN, Robert James
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152764360001
    GASKIN, Richard
    32 Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8JJ Leeds
    Amministratore
    32 Farrer Lane
    Oulton
    LS26 8JJ Leeds
    British97088460001
    GEORGEU, Peter
    209 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2BA St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    209 Park St Lane
    Park Street
    AL2 2BA St Albans
    Hertfordshire
    British38549410001
    GILLIGAN, Brendan Edward
    8 Thormanbay Lodge
    IRISH Howth
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    8 Thormanbay Lodge
    IRISH Howth
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrish227641150001
    GREGORY, Janet Ailsa
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    Eastwood Lodge
    Whitfield
    GL12 8EA Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British54836580002
    GUNNIGLE, Clodagh
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish138244630002
    HARVEY, David
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hatters Lane
    Croxley Green Business Park
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish97086950001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WOODCHESTER FINANCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hatters Lane
    2497
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Hatters Lane
    2497
    WD18 8YF Watford
    Building 4
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione962324
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WOODCHESTER FINANCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A new deposit charge
    Creato il 27 mar 2002
    Consegnato il 16 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies liabilities and amounts from lookers PLC (as borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All amounts standing to the credit of the deposit account opened in the name of general electric capital services inc. (The depositor), numbered 442101001 sub-account code "gecs" account name "cash deposit account with gecs" and any renewal or redesignation thereof all interest other rights benefits powers priverights benefits powers priveleges authorities discretions and remedies (of any nature whatsoever) accruing to or arising in connection with the same.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Bank Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 20 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no.9744714-10026 As the same may be redesignated supplemented or substituted from time to time (the account).
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 20 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no.974471410026 As the same may be redesignated supplemented or substituted from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no.9744714-10026 As the same may be redesignated supplemented or substituted from time to time see 395 12L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/10/90 as amended 28/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no.974471410018 As the same may be redesignated supplementedor substituted from time to time see 395 13L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/10/90 as amended 28/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no.97441410018 As the same may be redesignated supplemented or substituted from time to time see 395 14L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/10/90 as amended 28/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no. 974471410018 as the same may may be redesignated supplemented or substituted from time to time see 395 15L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no. 9744714-10026 as the same may be redesignated supplemented or substituted from time to time (the account) see 395 17L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Borrower account security agreement
    Creato il 30 ott 1992
    Consegnato il 16 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 14/3/91 and/or this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over the irish pound account of the chargor at hill samuel bank limited account no. 9744714-10026 see 395 16L 16/11 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    WOODCHESTER FINANCE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    2
    DataTipo
    29 giu 2017Inizio della liquidazione
    24 feb 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0