CARILLION CONSTRUCTION LIMITED

CARILLION CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARILLION CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00594581
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni

    Dove si trova CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pwc 8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TARMAC CONSTRUCTION LIMITED29 nov 195729 nov 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al07 mag 2018
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma21 mag 2018
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al07 mag 2017
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    6 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Indirizzo della sede legale modificato da , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 17 lug 2019

    2 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Modifica dei dettagli di Carillion Plc come persona con controllo significativo il 01 ott 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 01 ott 2018

    1 pagineAD01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    10 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    5 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    21 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    27 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    27 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    15 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    39 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    33 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    15 pagineNDISC

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    13 pagineNDISC

    Chi sono gli amministratori di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FITZHUGH, Dirk Olaf
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    Segretario
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    British612090001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235183600001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Segretario
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    British678610003
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Segretario
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    BAKER, Bryan William
    Little Hales House
    Chetwynd Aston
    TF10 9AW Newport
    Shropshire
    Amministratore
    Little Hales House
    Chetwynd Aston
    TF10 9AW Newport
    Shropshire
    British12567920001
    BOORMAN, Derek, Sir
    Lower Rowling Goodnestone
    CT3 1QA Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Lower Rowling Goodnestone
    CT3 1QA Canterbury
    Kent
    British62319660001
    BOOTH, Karen Jane
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish192636860001
    BOYES, Brian Chester
    Border Close The Crescent
    Woodlands Road Ashurst
    SO40 7AQ Southampton
    Hants
    Amministratore
    Border Close The Crescent
    Woodlands Road Ashurst
    SO40 7AQ Southampton
    Hants
    British11609460003
    BRYDEN, Gordon
    20 Dumville Drive
    RH9 8NY Godstone
    Surrey
    Amministratore
    20 Dumville Drive
    RH9 8NY Godstone
    Surrey
    British53913100004
    GELSTON, John Richard
    12 Longbridge Road
    WS14 9AL Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    12 Longbridge Road
    WS14 9AL Lichfield
    Staffordshire
    British9996190001
    GEORGEL, Brian
    Le Groeg 54 Clifton Road
    Tettenhall
    WV6 9AP Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Le Groeg 54 Clifton Road
    Tettenhall
    WV6 9AP Wolverhampton
    West Midlands
    British8675730001
    GILL, Matthew Clement Hugh
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish160968480002
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Amministratore
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    GREEN, Adam Richard
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish129918780001
    HAYWARD, Alan
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154549030001
    HERZBERG, Francis Robin
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish52429400001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    HURCOMB, David Stuart
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish34516340004
    KENNEDY, Francis Milne
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    British3792110001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    KIRK, Paul Robert
    4 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    United KingdomBritish29144870002
    LEDWIDGE, Joseph John
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    Amministratore
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    United KingdomBritish105384920001
    LUMBY, Richard Gregg
    Yew Tree House
    West Felton
    SY11 4EQ Oswestry
    Shropshire
    Amministratore
    Yew Tree House
    West Felton
    SY11 4EQ Oswestry
    Shropshire
    EnglandBritish65529640001
    MASON, Terence Harold
    Stratton Court
    Long Common
    WV5 7AX Claverley
    Shropshire
    Amministratore
    Stratton Court
    Long Common
    WV5 7AX Claverley
    Shropshire
    EnglandBritish3741500002
    MCDONOUGH, John
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    UkBritish74536340007
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    British110597480001
    MERCER, Emma Louise
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Amministratore
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish163383420001
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    MOORE, John
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    23 Hollington Way
    B90 4YD Solihull
    West Midlands
    British84441190001
    MYATT, Christopher John
    High Clere 166 Oulton Road
    ST15 8DR Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    High Clere 166 Oulton Road
    ST15 8DR Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish649790001
    OSBORNE, Alan
    Windtridge
    30 Ludlow Road
    WV16 5AF Bridgnorth
    Salop
    Amministratore
    Windtridge
    30 Ludlow Road
    WV16 5AF Bridgnorth
    Salop
    EnglandBritish108956240001
    PALMER, Martyn Charles
    Woodlands
    Church End, Bishampton
    WR10 2LT Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Woodlands
    Church End, Bishampton
    WR10 2LT Pershore
    Worcestershire
    United KingdomBritish203408350001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPublic Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3782379
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CARILLION CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 dic 2016
    Consegnato il 16 dic 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 16 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 lug 2011
    Consegnato il 29 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Elizabeth Property Nominee (No.3) Limited and Elizabeth Property Nominee (No.4) Limited as Trustees for the Elizabeth House Limited Partnership
    Transazioni
    • 29 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 dic 2007
    Consegnato il 15 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,625.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The rent deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Howard Lewisham Limited
    Transazioni
    • 15 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,037.50 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Rent deposit of £17,037.50.
    Persone aventi diritto
    • Howard Lewisham Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £4,406.25 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    Rent deposit of £4,406.25.
    Persone aventi diritto
    • Howard Lewisham Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 gen 2007
    Consegnato il 31 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • P & O Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 31 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The interest of the company in the account (as defined in the rent deposit deed).
    Persone aventi diritto
    • Robert Edward Gunn and Lynne Teresa Peacock
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 23 ago 1999
    Consegnato il 07 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 23 ago 1999
    Consegnato il 07 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 24 dic 1997
    Consegnato il 07 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee to pay the success fee and/or observe its obligations under the guarantee and additional fee agreement dated 24 december 1997
    Brevi particolari
    All present and future shares of baa-mcarthur/glen (mansfield) limited and/or baa-mcarthur/glen (swindon) limited and baa-mcarthur/glen (bridgend) limitedheld by or on behalf of the company and all dividends bonuses options etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 19 ott 1994
    Consegnato il 21 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 12TH september 1994 and a licence for alterations dated 19TH october 1994
    Brevi particolari
    The sum of £2,000 deposited by the company with the chargee in accordance with the terms of the deed and any interest accrued thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mark Charles Batten
    • John Francis Soden
    Transazioni
    • 21 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deposit agreement
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 24 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein acting together in a joint venture as translink joint venture to the chargee under the terms of a lease dated 21ST february 1994 and this agreement
    Brevi particolari
    The sum of £20,000 and all interest earned thereon deposited under the terms of the security deposit deed dated 21ST february 1994. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sencara Properties Limited
    Transazioni
    • 24 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 26 giu 1972
    Consegnato il 07 lug 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000
    Brevi particolari
    By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 07 lug 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 16 dic 1968
    Consegnato il 16 dic 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Third supplemental trust deed securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,652,725 inclusive of £5,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 16 dic 1968Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 17 lug 1967
    Consegnato il 17 lug 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Second supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £5,000,000 inclusive of £3,000,000 secured by two deeds dated 05/10/64 & 26/10/65 respectively
    Brevi particolari
    By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 17 lug 1967Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 26 ott 1965
    Consegnato il 09 nov 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £3,000,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64
    Brevi particolari
    First floating charge by way of security for the repayment by tarmac LTD of the debenture stock mentioned in col.3 On the undertaking of the company and all its property and assets both present and future (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 09 nov 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 05 ott 1964
    Consegnato il 04 ott 1964
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 debenture stock of tarmac LTD
    Brevi particolari
    First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 04 ott 1964Registrazione di un'ipoteca
    • 05 ago 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARILLION CONSTRUCTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 gen 2018Data della petizione
    15 gen 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0