CARILLION CONSTRUCTION LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CARILLION CONSTRUCTION LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Liquidazione |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00594581 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TARMAC CONSTRUCTION LIMITED | 29 nov 1957 | 29 nov 1957 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 07 mag 2018 |
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 21 mag 2018 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 07 mag 2017 |
| Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 6 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 5 pagine | NDISC | ||
Indirizzo della sede legale modificato da , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 17 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||
Modifica dei dettagli di Carillion Plc come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 10 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 5 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 5 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 21 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 27 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 27 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 15 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 39 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 33 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 15 pagine | NDISC | ||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 13 pagine | NDISC | ||
Chi sono gli amministratori di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITZHUGH, Dirk Olaf | Segretario | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183600001 | |||||||
| MCCORMACK, James Joseph | Segretario | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | 678610003 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Segretario | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| TAPP, Richard Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BAKER, Bryan William | Amministratore | Little Hales House Chetwynd Aston TF10 9AW Newport Shropshire | British | 12567920001 | ||||||
| BOORMAN, Derek, Sir | Amministratore | Lower Rowling Goodnestone CT3 1QA Canterbury Kent | British | 62319660001 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BOYES, Brian Chester | Amministratore | Border Close The Crescent Woodlands Road Ashurst SO40 7AQ Southampton Hants | British | 11609460003 | ||||||
| BRYDEN, Gordon | Amministratore | 20 Dumville Drive RH9 8NY Godstone Surrey | British | 53913100004 | ||||||
| GELSTON, John Richard | Amministratore | 12 Longbridge Road WS14 9AL Lichfield Staffordshire | British | 9996190001 | ||||||
| GEORGEL, Brian | Amministratore | Le Groeg 54 Clifton Road Tettenhall WV6 9AP Wolverhampton West Midlands | British | 8675730001 | ||||||
| GILL, Matthew Clement Hugh | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 160968480002 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Amministratore | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| GREEN, Adam Richard | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 129918780001 | |||||
| HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| HURCOMB, David Stuart | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 34516340004 | |||||
| KENNEDY, Francis Milne | Amministratore | Aughton 36 St Albans Road RH2 9LN Reigate Surrey | British | 3792110001 | ||||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KIRK, Paul Robert | Amministratore | 4 Beauchamp Gardens Myton Lane CV34 6QG Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 29144870002 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Amministratore | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| LUMBY, Richard Gregg | Amministratore | Yew Tree House West Felton SY11 4EQ Oswestry Shropshire | England | British | 65529640001 | |||||
| MASON, Terence Harold | Amministratore | Stratton Court Long Common WV5 7AX Claverley Shropshire | England | British | 3741500002 | |||||
| MCDONOUGH, John | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MCEWAN, Euan | Amministratore | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MERCER, Emma Louise | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 163383420001 | |||||
| MILLS, Lee James | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| MOORE, John | Amministratore | 23 Hollington Way B90 4YD Solihull West Midlands | British | 84441190001 | ||||||
| MYATT, Christopher John | Amministratore | High Clere 166 Oulton Road ST15 8DR Stone Staffordshire | England | British | 649790001 | |||||
| OSBORNE, Alan | Amministratore | Windtridge 30 Ludlow Road WV16 5AF Bridgnorth Salop | England | British | 108956240001 | |||||
| PALMER, Martyn Charles | Amministratore | Woodlands Church End, Bishampton WR10 2LT Pershore Worcestershire | United Kingdom | British | 203408350001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION CONSTRUCTION LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Plc | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CARILLION CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 09 dic 2016 Consegnato il 16 dic 2016 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 26 lug 2011 Consegnato il 29 lug 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 13 dic 2007 Consegnato il 15 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £17,625.00 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari The rent deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 nov 2007 Consegnato il 28 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £17,037.50 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari Rent deposit of £17,037.50. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 22 nov 2007 Consegnato il 28 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £4,406.25 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari Rent deposit of £4,406.25. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 26 gen 2007 Consegnato il 31 gen 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Monies from time to time standing to the credit of a designated deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 30 lug 2002 Consegnato il 06 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The interest of the company in the account (as defined in the rent deposit deed). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 23 ago 1999 Consegnato il 07 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 23 ago 1999 Consegnato il 07 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under clause 3 of the guarantee and additional fee agreement as defined | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all present and future shares and dividends by way of assignment the benefit to the company of the shareholders agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 24 dic 1997 Consegnato il 07 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee to pay the success fee and/or observe its obligations under the guarantee and additional fee agreement dated 24 december 1997 | |
Brevi particolari All present and future shares of baa-mcarthur/glen (mansfield) limited and/or baa-mcarthur/glen (swindon) limited and baa-mcarthur/glen (bridgend) limitedheld by or on behalf of the company and all dividends bonuses options etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit deed | Creato il 19 ott 1994 Consegnato il 21 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for lease dated 12TH september 1994 and a licence for alterations dated 19TH october 1994 | |
Brevi particolari The sum of £2,000 deposited by the company with the chargee in accordance with the terms of the deed and any interest accrued thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deposit agreement | Creato il 21 feb 1994 Consegnato il 24 feb 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein acting together in a joint venture as translink joint venture to the chargee under the terms of a lease dated 21ST february 1994 and this agreement | |
Brevi particolari The sum of £20,000 and all interest earned thereon deposited under the terms of the security deposit deed dated 21ST february 1994. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 26 giu 1972 Consegnato il 07 lug 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £2,750,000 | |
Brevi particolari By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 16 dic 1968 Consegnato il 16 dic 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Third supplemental trust deed securing debenture stock of tarmac derby LTD amounting to £7,652,725 inclusive of £5,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 and deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creato il 17 lug 1967 Consegnato il 17 lug 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Second supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £5,000,000 inclusive of £3,000,000 secured by two deeds dated 05/10/64 & 26/10/65 respectively | |
Brevi particolari By way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 26 ott 1965 Consegnato il 09 nov 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Supplemental trust deed for securing debenture stock of tarmac LTD amounting to £3,000,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed dated 05/10/64 | |
Brevi particolari First floating charge by way of security for the repayment by tarmac LTD of the debenture stock mentioned in col.3 On the undertaking of the company and all its property and assets both present and future (including uncalled capital). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 05 ott 1964 Consegnato il 04 ott 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,000,000 debenture stock of tarmac LTD | |
Brevi particolari First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
CARILLION CONSTRUCTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0