DARWINS HOLDINGS LIMITED

DARWINS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDARWINS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00594788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    • fusione di acciaio (24520) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    00594788 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS
    4385
    CF14 8LH Cardiff
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DARWINS ALLOY CASTINGS LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    DARWINS LIMITED04 dic 195704 dic 1957

    Quali sono gli ultimi bilanci di DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2019
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 dic 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 gen 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al31 dic 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Indirizzo della sede legale modificato a PO Box 4385, 00594788 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH il 14 nov 2023

    1 pagineRP05

    Indirizzo della sede legale modificato da Prospect Road Crook County Durham DL15 8JL England a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 28 giu 2021

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Robert Jon Blackett come amministratore in data 17 ago 2020

    1 pagineTM01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Ordinanza giudiziaria

    S1096 Court Order to Rectify
    2 pagineOC

    legacy

    pagineANNOTATION

    legacy

    pagineANNOTATION

    legacy

    pagineANNOTATION

    legacy

    pagineANNOTATION

    legacy

    pagineANNOTATION

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Prospect Road Prospect Road Crook County Durham DL15 8JL

    1 pagineAD04

    Cessazione della carica di Trevor John Machin come amministratore in data 01 ago 2019

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 005947880007

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 005947880006

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 005947880009

    5 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 005947880008

    5 pagineMR05

    Cessazione della carica di Michael John Best come amministratore in data 30 set 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 005947880009, creata il 29 mag 2018

    14 pagineMR01

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    34 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 005947880005 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 005947880008, creata il 24 apr 2018

    29 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BULL, Paul Antony
    7 Leveret Way
    Birstall
    WF17 0RP Batley
    West Yorkshire
    Segretario
    7 Leveret Way
    Birstall
    WF17 0RP Batley
    West Yorkshire
    British80053040001
    JOHNSON, Christopher Denis
    21 Cherry Grove
    RG17 0HP Hungerford
    Berkshire
    Segretario
    21 Cherry Grove
    RG17 0HP Hungerford
    Berkshire
    British2049270001
    MORTON, Tracy
    6 Romwood Avenue
    Swinton
    S64 8DX Mexborough
    South Yorkshire
    Segretario
    6 Romwood Avenue
    Swinton
    S64 8DX Mexborough
    South Yorkshire
    British28267190001
    PENNSEC LIMITED
    33 Gutter Lane
    EC2V 8AR London
    Abacus House
    Segretario nominato
    33 Gutter Lane
    EC2V 8AR London
    Abacus House
    900007060001
    ALVERSON, Luke Edward
    N. O'Connor Boulevard
    Suite 2300
    TX75039 Irving
    5205
    Texas
    United States
    Amministratore
    N. O'Connor Boulevard
    Suite 2300
    TX75039 Irving
    5205
    Texas
    United States
    UsaAmerican194498430001
    ARNOLD, Jurgen Manfred
    Aberjettenbacher Strabe 3
    Beilstein
    Baden Wurttenberg
    71717
    Germany
    Amministratore
    Aberjettenbacher Strabe 3
    Beilstein
    Baden Wurttenberg
    71717
    Germany
    German101217970001
    BARRETT, William Edward
    59584 Ridgewood Drive
    TR5 Goshen
    Indiana 46526
    United States Of America
    Amministratore
    59584 Ridgewood Drive
    TR5 Goshen
    Indiana 46526
    United States Of America
    Citizen Of Usa28267210002
    BEST, Michael John
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    Amministratore
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    EnglandBritish155918970001
    BLACKETT, Robert Jon
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    County Durham
    England
    Amministratore
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    County Durham
    England
    United KingdomBritish102005930002
    BULL, Paul Antony
    7 Leveret Way
    Birstall
    WF17 0RP Batley
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Leveret Way
    Birstall
    WF17 0RP Batley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish80053040001
    CRESSWELL, Roy
    Lower Cote Farm
    Clough Lane
    HD6 3QN Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lower Cote Farm
    Clough Lane
    HD6 3QN Brighouse
    West Yorkshire
    British28267220001
    DUNCAN, Paul Robson
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    Amministratore
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    EnglandBritish38147460006
    GRAHAM, Stephen James
    10 Brownberrie Avenue
    Horsforth
    LS18 5PN Leeds
    Amministratore
    10 Brownberrie Avenue
    Horsforth
    LS18 5PN Leeds
    EnglandBritish251134450001
    HAMPSON, Shaun Michael
    43 St Chad's Close
    ST15 8QA Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    43 St Chad's Close
    ST15 8QA Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish111493760001
    HELL, Harald
    Lindenstrasse 170
    25524 Itzehoe
    Sterling Fluid Systems Holdings Gmbh
    Schleswig - Holstein
    Germany
    Amministratore
    Lindenstrasse 170
    25524 Itzehoe
    Sterling Fluid Systems Holdings Gmbh
    Schleswig - Holstein
    Germany
    GermanyGerman175739370001
    HERRON, Patrick Thomas
    87 Redmires Road
    S10 4LB Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    87 Redmires Road
    S10 4LB Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish80211430001
    JOHNSON, Christopher Denis
    21 Cherry Grove
    RG17 0HP Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    21 Cherry Grove
    RG17 0HP Hungerford
    Berkshire
    British2049270001
    LUKES, Antony John
    1 Rickyard
    Water Lane Sherington
    MK16 9NP Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Rickyard
    Water Lane Sherington
    MK16 9NP Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British40630250001
    MACHIN, Trevor John
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    Amministratore
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    Prospect Road
    County Durham
    England
    EnglandBritish216323700001
    MCMAHON, Roger
    19 Conisboro Avenue
    Caversham Caversham Heights
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    Amministratore
    19 Conisboro Avenue
    Caversham Caversham Heights
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    EnglandBritish91757070001
    MEEHAN, Kevin Anthony
    Hawton Lane
    Balderton
    NG24 3BU Newark
    Flowserve Gb Ltd
    Notts
    Amministratore
    Hawton Lane
    Balderton
    NG24 3BU Newark
    Flowserve Gb Ltd
    Notts
    UkBritish429350003
    MOHRDIECK, Erich
    Sachsenweg 12
    Uremper Heide
    Schleswig- Holstein 25569
    Germany
    Amministratore
    Sachsenweg 12
    Uremper Heide
    Schleswig- Holstein 25569
    Germany
    GermanyGerman101300880001
    O'KELLY, Paul Brian
    Bagley Edge Badger Lane
    OX1 5BL Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bagley Edge Badger Lane
    OX1 5BL Oxford
    Oxfordshire
    British59017540001
    ONSLOW, Alexander
    St. Marys Road
    Penketh
    WA5 2DT Warrington
    13
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    St. Marys Road
    Penketh
    WA5 2DT Warrington
    13
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136916820001
    SALIBA, Jacob
    4368 Prudential Tower
    Boston
    Massachusettes 02199
    United States Of America
    Amministratore
    4368 Prudential Tower
    Boston
    Massachusettes 02199
    United States Of America
    Citizen Of Usa28267200001
    SHEVLIN, Owen
    2 The Rickyard
    OX12 8PG Ardington
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 The Rickyard
    OX12 8PG Ardington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish92220480001
    SMITH, Timothy John
    Greenacre Church Road
    Crowfield
    IP6 9TG Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Greenacre Church Road
    Crowfield
    IP6 9TG Ipswich
    Suffolk
    British21179610001
    TRITTIN, Wolfgang Ernst
    Rosenstrasse 9
    Gallingen
    D-78262
    Germany
    Amministratore
    Rosenstrasse 9
    Gallingen
    D-78262
    Germany
    German78574580001
    TUBB, Ronald
    Lower Butts
    Llangarron
    HR9 6PA Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Lower Butts
    Llangarron
    HR9 6PA Ross On Wye
    Herefordshire
    British22789450001
    WEAVER, Barry Reginald
    Wegzoll 5
    FOREIGN Hamburg
    22393
    Germany
    Amministratore
    Wegzoll 5
    FOREIGN Hamburg
    22393
    Germany
    GermanyBritish79189210001
    WINDMILL, Robert John
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    Amministratore delegato nominato
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    British900004660001
    WITTEKINDT, Widu, Doctor
    Fliederstrasse 16
    Achim
    28832
    Germany
    Amministratore
    Fliederstrasse 16
    Achim
    28832
    Germany
    German71187630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DARWINS HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bonddarwin Limited
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    1
    England
    06 apr 2016
    Prospect Road
    DL15 8JL Crook
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione09750341
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DARWINS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 mag 2018
    Consegnato il 31 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    A legal assignment of contract monies.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 dic 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 25 apr 2018
    Consegnato il 25 apr 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 25 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 dic 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2018
    Consegnato il 08 mag 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 08 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 dic 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 24 apr 2018
    Consegnato il 26 apr 2018
    In corso
    Breve descrizione
    By way of legal mortgage all freehold (including commonhold) and leasehold land at the date of the debenture vested in the company together with all buildings fixtures, fittings and fixed plant and machinery as at the date of the debenture or at any time afterwards on it.. By way of first fixed charge all the present and future right, title and interest of the company in or to any freehold (including commonhold) or leasehold land or other immovable property wherever situated and all fixtures, fittings and fixed plant and machinery at the date of the debenture or at any time afterwards on it.. By way of first fixed charge all patents, trademarks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know-how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) at the date of the debenture or at any time afterwards belonging to the company.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 dic 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 29 lug 2016
    Consegnato il 01 ago 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2015
    Consegnato il 30 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 30 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 nov 2015
    Consegnato il 10 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    A fixed and floating charge over all assets.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 nov 2005
    Consegnato il 29 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge of intragroup loans and intragroup receivables
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower and guarantor to the secured creditors (or any of them)
    Brevi particolari
    By way of floating charge the secured rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0