EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00595835 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 005958350022 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 005958350023 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Angus Alexander Dodd come amministratore in data 07 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 15 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Angus Alexander Dodd il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Frances Victoria Heazell il 01 dic 2017 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Ben Jenkins il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Rajesh Shah il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. James Michael Edward Saunders il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 005958350023, creata il 03 nov 2017 | 134 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Michael Ben Jenkins come amministratore in data 13 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Simon Geoffrey Carter come amministratore in data 13 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Segretario | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875650001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SHAH, Rajesh | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 150630770001 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| COOK, Anthony | Segretario | Flat 81 Darwin Court 2-24 Gloucester Avenue NW1 7BQ London | British | 8492960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104140001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Segretario | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GILL, Anthony Douglas | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 178214790001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| JONES, Christopher Neville | Amministratore | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| STRINGER, Reginald | Amministratore | Pipers Landing Green Lane Albury GU5 9EP Guildford | British | 11500100002 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Amministratore | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WINGATE, Stephan Anthony | Amministratore | 58 Pont Street SW1X 0AE London | United Kingdom | British | 33528820002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Amministratore | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estates Property Investment Company Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 03 nov 2017 Consegnato il 09 nov 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 nov 2016 Consegnato il 15 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 01 feb 2002 Consegnato il 08 feb 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates proerty investment company limited and all other monies secured by the deed and trust deed dated 28TH april 1986 (the principal deed) and all deeds supplemental thereto | |
Brevi particolari The capital sum of £7,880,000. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 25 giu 2001 Consegnato il 29 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and the deeds supplemental thereto of various dates | |
Brevi particolari F/H land and buildings k/a centre heights 135-151 finchley road london NW3 t/n NGL716912 and adjacent land forming part of the frontage to belsize road t/n NGL459004, assigned all moneys payable by virtue of any insurances on the new property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 16 gen 2001 Consegnato il 22 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28TH april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates | |
Brevi particolari The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as defined in the principal deed). The leasehold property at 2/10 trinity street, coventry CV1 1FL. Title number WM692715. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of covenant | Creato il 31 mar 2000 Consegnato il 14 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 (the "stock") of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the hereinbefore described deed of covenant dated 31 march 2000 and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates | |
Brevi particolari The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as descrobed in the principal deed) including (without prejudice to the generality of the foregoing) insurance effected pursuant to clauses 16(m) & 16(n)(subject as thereby provided) of the principal deed. The f/h land and buildings on the north-west side of broad green road,lakeside industrial estate,redditch,hereford and worcester.t/no.HW162933. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & lucas office enviroments (scotland) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emaco limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emstar limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & C.A. industrial finance limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & james clark. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rental income | Creato il 15 apr 1993 Consegnato il 27 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The companys rights to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & kavo dental limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 24 mar 1993 Consegnato il 05 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter & overdraft facility letter dated 24/3/93 (as defined in the charge) | |
Brevi particolari The benefit of the rents licence fees tenancies or licences in f/h property k/a units 5 & 6 athena ave, elgin drive industrial est, swindon t/no WT6 4045 & f/a property k/a blocks g s & m the james est, mitcham t/no sy 278922. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 24 mar 1993 Consegnato il 30 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings at kembry street and elgin drive k/a units 5 and 6 elgin drive ind: est: swindon wiltshire tog: with all buildings and fixtures and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 24 mar 1993 Consegnato il 30 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on south east of bond road k/a blocks g,s & m,the james estate tog: with all buildings and fixtures, goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security regdin scotland | Creato il 02 ago 1990 Consegnato il 10 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due or to become due from the development and realisation trust limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Epic house, 28/32 cadogan street, glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and charge | Creato il 17 mar 1989 Consegnato il 04 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys due to the charge secured by the trust deed dated 28TH april 1986 as ameaded and supplemented. | |
Brevi particolari F/H property at camberwell in london borough of southwark having a frontage to daneville road orpwells street denmark hill and wrean road t/n sgl 444643.together with all buildings, erections and fittings fixtures fixed plant as machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security reg in scotland 24.10.86. | Creato il 04 nov 1986 Consegnato il 05 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 28/32 cadogan street glasgow. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 28 apr 1986 Consegnato il 30 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all of her monies intended to be secured by the said trust deed | |
Brevi particolari L/Hold land k/as 110 euston road, londont/n ngl 148020 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. For full details see doc M68. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter | Creato il 18 apr 1986 Consegnato il 02 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £780,000 all monies due or to become due fro the company under the terms of the principal mortgage dated 21.5.71 | |
Brevi particolari Cash sum of sterling pound 780,000 deposited with charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 22 set 1977 Consegnato il 06 ott 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For futher securing debentures stock of estates property investment company amounting to £1700000 securies by a trust deed dated 4/9/63 | |
Brevi particolari Central buildings brook st wrexham comprised in a conveyance dated 26/3/64. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 04 set 1963 Consegnato il 04 set 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 1.700.000 debenture stock of estates property investment company LTD | |
Brevi particolari Various properties in kent, london staffs, sheffield and bristol (for details see doc. 29). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0