EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED

EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00595835
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 005958350022 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 005958350023 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Angus Alexander Dodd come amministratore in data 07 nov 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Angus Alexander Dodd il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Frances Victoria Heazell il 01 dic 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Ben Jenkins il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Rajesh Shah il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. James Michael Edward Saunders il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 005958350023, creata il 03 nov 2017

    134 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Ben Jenkins come amministratore in data 13 gen 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Simon Geoffrey Carter come amministratore in data 13 gen 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875650001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SHAH, Rajesh
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish150630770001
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish267205160001
    COOK, Anthony
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    Segretario
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    British8492960001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104140001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Segretario
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Amministratore
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Amministratore
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GILL, Anthony Douglas
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish178214790001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    JONES, Christopher Neville
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    Amministratore
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    EnglandBritish109266700001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    STRINGER, Reginald
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    Amministratore
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    British11500100002
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Amministratore
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WINGATE, Stephan Anthony
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Amministratore
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    United KingdomBritish33528820002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002

    Chi sono le persone con controllo significativo di EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione666487
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EPIC COMMERCIAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2017
    Consegnato il 09 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Homes and Communities Agency
    Transazioni
    • 09 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2016
    Consegnato il 15 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London, WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge and release
    Creato il 01 feb 2002
    Consegnato il 08 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates proerty investment company limited and all other monies secured by the deed and trust deed dated 28TH april 1986 (the principal deed) and all deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    The capital sum of £7,880,000.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge and release
    Creato il 25 giu 2001
    Consegnato il 29 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and the deeds supplemental thereto of various dates
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a centre heights 135-151 finchley road london NW3 t/n NGL716912 and adjacent land forming part of the frontage to belsize road t/n NGL459004, assigned all moneys payable by virtue of any insurances on the new property.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 apr 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge and release
    Creato il 16 gen 2001
    Consegnato il 22 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28TH april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates
    Brevi particolari
    The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as defined in the principal deed). The leasehold property at 2/10 trinity street, coventry CV1 1FL. Title number WM692715.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 22 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenant
    Creato il 31 mar 2000
    Consegnato il 14 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent.first mortgage debenture stock 2011 (the "stock") of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by the hereinbefore described deed of covenant dated 31 march 2000 and the trust deed dated 28 april 1986 (the "principal deed") and also the deeds supplemental thereto of various dates
    Brevi particolari
    The company has assigned to the trustees all moneys payable by virtue of any insurance on the specific security (as descrobed in the principal deed) including (without prejudice to the generality of the foregoing) insurance effected pursuant to clauses 16(m) & 16(n)(subject as thereby provided) of the principal deed. The f/h land and buildings on the north-west side of broad green road,lakeside industrial estate,redditch,hereford and worcester.t/no.HW162933.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 14 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & lucas office enviroments (scotland) limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emaco limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & emstar limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & C.A. industrial finance limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys right to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & james clark. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation of rental income
    Creato il 15 apr 1993
    Consegnato il 27 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The companys rights to receive & the full benefit of the rentals including rentals arising out of a lease between the company & kavo dental limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 05 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a facility letter & overdraft facility letter dated 24/3/93 (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    The benefit of the rents licence fees tenancies or licences in f/h property k/a units 5 & 6 athena ave, elgin drive industrial est, swindon t/no WT6 4045 & f/a property k/a blocks g s & m the james est, mitcham t/no sy 278922.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 30 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at kembry street and elgin drive k/a units 5 and 6 elgin drive ind: est: swindon wiltshire tog: with all buildings and fixtures and goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 30 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on south east of bond road k/a blocks g,s & m,the james estate tog: with all buildings and fixtures, goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security regdin scotland
    Creato il 02 ago 1990
    Consegnato il 10 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the development and realisation trust limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Epic house, 28/32 cadogan street, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and charge
    Creato il 17 mar 1989
    Consegnato il 04 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys due to the charge secured by the trust deed dated 28TH april 1986 as ameaded and supplemented.
    Brevi particolari
    F/H property at camberwell in london borough of southwark having a frontage to daneville road orpwells street denmark hill and wrean road t/n sgl 444643.together with all buildings, erections and fittings fixtures fixed plant as machinery.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 04 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security reg in scotland 24.10.86.
    Creato il 04 nov 1986
    Consegnato il 05 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    28/32 cadogan street glasgow.
    Persone aventi diritto
    • National Provident Institution
    Transazioni
    • 05 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 28 apr 1986
    Consegnato il 30 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pound 11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all of her monies intended to be secured by the said trust deed
    Brevi particolari
    L/Hold land k/as 110 euston road, londont/n ngl 148020 together with all buildings and erections and fixtures (including tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. For full details see doc M68.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter
    Creato il 18 apr 1986
    Consegnato il 02 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £780,000 all monies due or to become due fro the company under the terms of the principal mortgage dated 21.5.71
    Brevi particolari
    Cash sum of sterling pound 780,000 deposited with charge.
    Persone aventi diritto
    • National Provident Institution
    Transazioni
    • 02 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 22 set 1977
    Consegnato il 06 ott 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For futher securing debentures stock of estates property investment company amounting to £1700000 securies by a trust deed dated 4/9/63
    Brevi particolari
    Central buildings brook st wrexham comprised in a conveyance dated 26/3/64.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 06 ott 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 04 set 1963
    Consegnato il 04 set 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    1.700.000 debenture stock of estates property investment company LTD
    Brevi particolari
    Various properties in kent, london staffs, sheffield and bristol (for details see doc. 29).
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Company LTD
    Transazioni
    • 04 set 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0