ENVOPAK GROUP
Panoramica
Nome della società | ENVOPAK GROUP |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 00596706 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ENVOPAK GROUP?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ENVOPAK GROUP?
Indirizzo della sede legale | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ENVOPAK GROUP?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ENVOPAK LIMITED | 08 gen 1958 | 08 gen 1958 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ENVOPAK GROUP?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per ENVOPAK GROUP?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2008 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2007 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2006 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c |
Chi sono gli amministratori di ENVOPAK GROUP?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S & J REGISTRARS LIMITED | Segretario | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Tax Manager | 140644240001 | ||||||||
DEAKIN, Philip Matthew | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 146225080002 | ||||||||
HUDSON, Giles Matthew | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 161583790001 | ||||||||
UFLAND, Edward | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 87558180001 | ||||||||
HOULDSWORTH, Raymond | Segretario | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | Chartered Accountant | 28059370001 | |||||||||
PIPER, Maurice George | Segretario | 8 Chestnut Lane Matfield TN12 7JL Tonbridge Kent | British | 8141120001 | ||||||||||
PROBERT, Clive Michael Douglas | Segretario | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | Company Secretary | 10804410001 | |||||||||
WICKETT, Edna May | Segretario | 55 Ladbrooke Crescent Albany Park DA14 4RU Sidcup Kent | British | Company Secretary | 36891520001 | |||||||||
WILLIAMS, Ian Ralph | Segretario | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | Accountant | 19140250001 | |||||||||
ARTHUR, Frank Henry | Amministratore | Well Hill Cottage Well Hill BR6 7RL Chelsfield Kent | England | British | Inventor | 8141130001 | ||||||||
BANGLE, Alfred Richard George | Amministratore | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | Sales Dir | 20981040001 | |||||||||
BANGLE, Alfred Richard George | Amministratore | 48 Princes Avenue Minster On Sea ME12 2HJ Isle Of Sheppey Kent | British | Sales Dir | 20981040001 | |||||||||
BLACK, Stephen | Amministratore | Les Vielles Terres Havelet GY1 1AZ St Peter Port Guernsey | British | Businessman | 73554610001 | |||||||||
CAMERON, Ian Donald | Amministratore | The Old Rectory Peasemore RG16 0JH Newbury Berkshire | British | Stockbroker | 13521010001 | |||||||||
HENSHAW, Robert Charles Mayon | Amministratore | 89 Sherbrooke Road SW6 7QL London | British | Company Director | 66661330001 | |||||||||
HOLLINGSWORTH, Roger Colin | Amministratore | 97 Copse Avenue BR4 9NW West Wickham Kent | British | Registered Insurance Broker | 20963700001 | |||||||||
HOULDSWORTH, Raymond | Amministratore | 26 York Road Chingford E4 8QN London | British | Chartered Accountant | 28059370001 | |||||||||
KIRBY, Robert Bernard | Amministratore | 1 Manor House Drive Crawford WN8 9QZ Upholland Lancashire | England | British | Production Dir | 221394890001 | ||||||||
LEWIS, Thomas Arwyn | Amministratore | 35 Clos Glanlliw Pontlliw SA4 9DW Swansea West Glamorgan | British | Accountant | 65122490001 | |||||||||
O'DOHERTY, Jean Crichton | Amministratore | 2g The Glebe Blackheath SE3 9TT London | England | British | Director | 13964410001 | ||||||||
PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir | Amministratore | Kings Walden Bury SG4 8JU Hitchin Herts | England | British | Company Director | 5324930001 | ||||||||
PROBERT, Clive Michael Douglas | Amministratore | Cefn Bryn Cottage Penmaen SA3 2HQ Swansea West Glamorgan | British | Company Secretary | 10804410001 | |||||||||
REED, Peter John | Amministratore | 116 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | Financial Director | 21740620001 | |||||||||
UDALL, Gavin | Amministratore | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Accountant | 83889580001 | ||||||||
UDELHOFEN, Mark James | Amministratore | 771 Revere Road Glen Ellyn Illinois 60137 Usa | American | General Manager | 84364350001 | |||||||||
WILLIAMS, Ian Ralph | Amministratore | Littledown Cottage Vernham Dean SP11 0EF Andover Hampshire | British | Accountant | 19140250001 |
ENVOPAK GROUP ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 13 nov 2000 Consegnato il 16 nov 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 22 lug 1998 Consegnato il 25 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 30 giu 1995 Consegnato il 06 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 mar 1993 Consegnato il 06 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 31 mar 1987 Consegnato il 03 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 16 mar 1987 Consegnato il 20 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 29 set 1986 Consegnato il 20 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 14 lug 1970 Consegnato il 29 lug 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD. | |
Brevi particolari Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 14 giu 1968 Consegnato il 28 giu 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 06 gen 1965 Consegnato il 07 gen 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc | |
Brevi particolari Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0