ENVOPAK GROUP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENVOPAK GROUP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00596706
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENVOPAK GROUP?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ENVOPAK GROUP?

    Indirizzo della sede legale
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENVOPAK GROUP?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENVOPAK LIMITED08 gen 195808 gen 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENVOPAK GROUP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ENVOPAK GROUP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 nov 2011

    Stato del capitale al 30 nov 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2007

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2006

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di ENVOPAK GROUP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishTax Manager140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritishChartered Accountant87558180001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Segretario
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    BritishChartered Accountant28059370001
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    Segretario
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Segretario
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Secretary10804410001
    WICKETT, Edna May
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    Segretario
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    BritishCompany Secretary36891520001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Segretario
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    BritishAccountant19140250001
    ARTHUR, Frank Henry
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    Amministratore
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    EnglandBritishInventor8141130001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Amministratore
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    BritishSales Dir20981040001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    Amministratore
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    BritishSales Dir20981040001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    BritishBusinessman73554610001
    CAMERON, Ian Donald
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    BritishStockbroker13521010001
    HENSHAW, Robert Charles Mayon
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    Amministratore
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    BritishCompany Director66661330001
    HOLLINGSWORTH, Roger Colin
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    Amministratore
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    BritishRegistered Insurance Broker20963700001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    Amministratore
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    BritishChartered Accountant28059370001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    Amministratore
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritishProduction Dir221394890001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    BritishAccountant65122490001
    O'DOHERTY, Jean Crichton
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    Amministratore
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglandBritishDirector13964410001
    PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    Amministratore
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    EnglandBritishCompany Director5324930001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    Amministratore
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    BritishCompany Secretary10804410001
    REED, Peter John
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Amministratore
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    BritishFinancial Director21740620001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishAccountant83889580001
    UDELHOFEN, Mark James
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    Amministratore
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    AmericanGeneral Manager84364350001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    BritishAccountant19140250001

    ENVOPAK GROUP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 nov 2000
    Consegnato il 16 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 lug 1998
    Consegnato il 25 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 27 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 1993
    Consegnato il 06 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mar 1987
    Consegnato il 03 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 mar 1987
    Consegnato il 20 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 1986
    Consegnato il 20 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 lug 1970
    Consegnato il 29 lug 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Charente Steamship Co LTD
    Transazioni
    • 29 lug 1970Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 14 giu 1968
    Consegnato il 28 giu 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 giu 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 06 gen 1965
    Consegnato il 07 gen 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc
    Brevi particolari
    Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0