FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED

FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00598098
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    1 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Andrew Tatford il 31 ago 2018

    2 pagineCH01

    Notifica di Qcc Holdings Limited come persona con controllo significativo il 26 mar 2018

    4 paginePSC02

    Cessazione di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 26 mar 2018

    3 paginePSC07

    Modifica dei dettagli di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Alexander Edward Compton Hare il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Andrew Tatford il 01 dic 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Alexander Edward Compton Hare il 12 lug 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 17 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Andrew Tatford come amministratore in data 17 mar 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come amministratore in data 05 ott 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARE, Alexander Edward Compton, Mr
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish215786330002
    TATFORD, Simon Andrew
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish228195340002
    COOK, Anthony
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    Segretario
    Flat 81 Darwin Court
    2-24 Gloucester Avenue
    NW1 7BQ London
    British8492960001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    175104180001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Segretario
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    DUGDALE, Edward Stratford
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    Amministratore
    Tickwood Hall
    TF13 6NZ Much Wenlock
    Shropshire
    EnglandBritish35942980003
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    GAVAGHAN, David Nicholas
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    Amministratore
    16 Grosvenor Street
    London
    W1K 4QF
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HAMILTON STUBBER, James Robert
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    Amministratore
    1 The Regency
    Hide Place
    SW1P 4HD London
    United KingdomBritish84913850002
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish164108510002
    JONES, Christopher Neville
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    Amministratore
    55 York Mews
    GU34 1JD Alton
    Hampshire
    EnglandBritish109266700001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish132142980001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001
    STEARN, Richard James
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish94050800002
    STRINGER, Reginald
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    Amministratore
    Pipers Landing
    Green Lane Albury
    GU5 9EP Guildford
    British11500100002
    WILLIAMS, Brian
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    Amministratore
    14 Shirley Avenue
    Cheam
    SM2 7QR Sutton
    Surrey
    British9303850001
    WINGATE, Stephan Anthony
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    Amministratore
    58 Pont Street
    SW1X 0AE London
    United KingdomBritish33528820002
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritish130493170001
    WYATT, Adrian Roger
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Broom Manor
    Cottered
    SG9 9QE Buntingford
    Hertfordshire
    EnglandBritish42858810002

    Chi sono le persone con controllo significativo di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    26 mar 2018
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11193711
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione666487
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental trust deed
    Creato il 24 mar 1993
    Consegnato il 29 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,000,000 10% secured loan stock 1993/98 and all other monies due from estates property investment company limited to sun alliance trust company limited pursuant to the second supplemental trust deed dated 29TH march 1993
    Brevi particolari
    Land and premises k/a ramus tiles unit broad ground road lakeside west reddich county of hereford and worcester.
    Persone aventi diritto
    • Sun Alliance Trust Company Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and charge
    Creato il 17 giu 1991
    Consegnato il 24 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by a deed dated 28TH april 1986, deeds supplemental thereto and this charge.
    Brevi particolari
    F/H land and buildings known as ramus tiles unit, broad ground road, lakeside west, redditch, hereford and worcester.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited.
    Transazioni
    • 24 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 gen 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 12 lug 1990
    Consegnato il 13 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on the south side of bond road, mitcham and k/a blocks g, s & m, the james estate assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental mortgage and release
    Creato il 08 giu 1989
    Consegnato il 15 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,600,000 due from the company to the chargee. Under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The ramus tiles, unit, broadground road, redditch hereford and worcestershire.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 15 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental mortgage and release
    Creato il 22 mar 1989
    Consegnato il 30 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,115,500 & all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 25.3.76 and legal charges dated 30.9.76 and 16.12.77
    Brevi particolari
    F/H- units E7, f and H5, stanley green trading estate situated in cheadle hulme, great manchester and wilmslow, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Royal Insurance PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 feb 1989
    Consegnato il 23 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to south of stanley green road, cheadle hulme, greater manchester and wilmslow, cheshire k/a units D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, g, k, a, p and E1 at stanley green trading estate and unit 2/1 at stanley green trading estate (formerley title no ch 221436 and part of no. Ch 196140). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1988
    Consegnato il 25 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or estates property investments company limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    St. Georges business park, situate at locke king road and brooklands road weybridge, surrey title no sy 262247.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 feb 1993Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 04 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of release & charge
    Creato il 15 gen 1988
    Consegnato il 18 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 28.4.86.
    Brevi particolari
    F/H land at broad ground road lakeside west redditch hereford & worcester tog with all buildings & erections fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 18 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 14 ott 1986
    Consegnato il 16 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £780,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Supplemental to a mortgage 21/5/71
    Brevi particolari
    F/Hold unit E7 stanley green trading estate cheadle hulme cheshire.
    Persone aventi diritto
    • National Provident Institution
    Transazioni
    • 16 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit B1 stanley green trading estate, cheadle hulme cheshire together with all buildings and fixed plant, machinery and fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 1986
    Consegnato il 09 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit r s and u stover trading estate yate bristol avon. Together with all buildings, fixed plant, machinery and fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 09 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 28 apr 1986
    Consegnato il 30 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estate property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed
    Brevi particolari
    Various l/hold and f/hold properties in cheshire, greater manchester and leeds. Together with all buildings and erections and fixtures (includign tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being cheseam see doc M132 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 01 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Part of the james estate western rd, mitcham, surrey known as unit 1.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 01 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Units E9, E10 & E11 stanley green trading estate, cheadle hulme, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 01 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or estates property investment co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Units a, t & W. stover trading estate, yate, avon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 apr 1986
    Consegnato il 30 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company under the terms of the charge and/or estates property investment company PLC to the chargee
    Brevi particolari
    Units a and p stanley green trading estate cheadle hulme cheshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Manufacturers Hanower Trust Company
    Transazioni
    • 30 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 mar 1985
    Consegnato il 04 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north westside of tribune drive sittingbourne kent. (See doc m 129 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 mag 1984
    Consegnato il 12 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north west & south east sides of tribune drive, sittingbourne, kent together with the buildings and all fixed plant machiner & fixtures thereon. Title no. K 254683.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, p and q stover trading estate, yate, bristol together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures therein.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units a-h seacroft industrial estate, coal road, seacroft, leeds. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures therein.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units 1-3 bessemer road, cardiff, together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of elland road leeds. West yorkshire. Title no. Yk 9717. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north west of cheatsey road, byfleet, woking, surrey, title no. Sy 300102. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixture thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units D8, D9, D10/11 stanley green trading estate, cheadle, hulme cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 apr 1984
    Consegnato il 11 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Units D1/D2, d 3/4, D5, D6 and D7 stanley green grading estage, cheadle, hulme, cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 11 mag 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0