FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00598098 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di beni vacanti | 1 pagine | BONA | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Ripristino per ordine del tribunale | 1 pagine | AC92 | ||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Andrew Tatford il 31 ago 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Notifica di Qcc Holdings Limited come persona con controllo significativo il 26 mar 2018 | 4 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 26 mar 2018 | 3 pagine | PSC07 | ||
Modifica dei dettagli di Estates Property Investment Company Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Alexander Edward Compton Hare il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Andrew Tatford il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ in data 03 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Alexander Edward Compton Hare il 12 lug 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 9 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 17 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Simon Andrew Tatford come amministratore in data 17 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come amministratore in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARE, Alexander Edward Compton, Mr | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 215786330002 | |||||
| TATFORD, Simon Andrew | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 228195340002 | |||||
| COOK, Anthony | Segretario | Flat 81 Darwin Court 2-24 Gloucester Avenue NW1 7BQ London | British | 8492960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104180001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Segretario | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 164108510002 | |||||
| JONES, Christopher Neville | Amministratore | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| ODELL, Sandra Judith | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 132142980001 | |||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| STRINGER, Reginald | Amministratore | Pipers Landing Green Lane Albury GU5 9EP Guildford | British | 11500100002 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Amministratore | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WINGATE, Stephan Anthony | Amministratore | 58 Pont Street SW1X 0AE London | United Kingdom | British | 33528820002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Amministratore | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qcc Holdings Limited | 26 mar 2018 | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Estates Property Investment Company Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
FACTORY HOLDINGS GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Second supplemental trust deed | Creato il 24 mar 1993 Consegnato il 29 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 10% secured loan stock 1993/98 and all other monies due from estates property investment company limited to sun alliance trust company limited pursuant to the second supplemental trust deed dated 29TH march 1993 | |
Brevi particolari Land and premises k/a ramus tiles unit broad ground road lakeside west reddich county of hereford and worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and charge | Creato il 17 giu 1991 Consegnato il 24 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company limited and all other moneys intended to be secured by a deed dated 28TH april 1986, deeds supplemental thereto and this charge. | |
Brevi particolari F/H land and buildings known as ramus tiles unit, broad ground road, lakeside west, redditch, hereford and worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 12 lug 1990 Consegnato il 13 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings on the south side of bond road, mitcham and k/a blocks g, s & m, the james estate assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental mortgage and release | Creato il 08 giu 1989 Consegnato il 15 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,600,000 due from the company to the chargee. Under the terms of the charge | |
Brevi particolari The ramus tiles, unit, broadground road, redditch hereford and worcestershire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental mortgage and release | Creato il 22 mar 1989 Consegnato il 30 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,115,500 & all other monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 25.3.76 and legal charges dated 30.9.76 and 16.12.77 | |
Brevi particolari F/H- units E7, f and H5, stanley green trading estate situated in cheadle hulme, great manchester and wilmslow, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 feb 1989 Consegnato il 23 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings lying to south of stanley green road, cheadle hulme, greater manchester and wilmslow, cheshire k/a units D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, g, k, a, p and E1 at stanley green trading estate and unit 2/1 at stanley green trading estate (formerley title no ch 221436 and part of no. Ch 196140). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 18 nov 1988 Consegnato il 25 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or estates property investments company limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari St. Georges business park, situate at locke king road and brooklands road weybridge, surrey title no sy 262247. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release & charge | Creato il 15 gen 1988 Consegnato il 18 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estates property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by a trust deed dated 28.4.86. | |
Brevi particolari F/H land at broad ground road lakeside west redditch hereford & worcester tog with all buildings & erections fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 14 ott 1986 Consegnato il 16 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £780,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Supplemental to a mortgage 21/5/71 | |
Brevi particolari F/Hold unit E7 stanley green trading estate cheadle hulme cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 mag 1986 Consegnato il 09 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit B1 stanley green trading estate, cheadle hulme cheshire together with all buildings and fixed plant, machinery and fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 mag 1986 Consegnato il 09 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit r s and u stover trading estate yate bristol avon. Together with all buildings, fixed plant, machinery and fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 28 apr 1986 Consegnato il 30 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of estate property investment company PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed | |
Brevi particolari Various l/hold and f/hold properties in cheshire, greater manchester and leeds. Together with all buildings and erections and fixtures (includign tenants and trade fixtures) and fixed plant and machinery for the time being cheseam see doc M132 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 apr 1986 Consegnato il 01 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Part of the james estate western rd, mitcham, surrey known as unit 1. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 apr 1986 Consegnato il 01 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or estates property investments co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Units E9, E10 & E11 stanley green trading estate, cheadle hulme, cheshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 apr 1986 Consegnato il 01 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or estates property investment co. P.L.C. to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Units a, t & W. stover trading estate, yate, avon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 16 apr 1986 Consegnato il 30 apr 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company under the terms of the charge and/or estates property investment company PLC to the chargee | |
Brevi particolari Units a and p stanley green trading estate cheadle hulme cheshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 mar 1985 Consegnato il 04 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north westside of tribune drive sittingbourne kent. (See doc m 129 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 mag 1984 Consegnato il 12 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings on the north west & south east sides of tribune drive, sittingbourne, kent together with the buildings and all fixed plant machiner & fixtures thereon. Title no. K 254683. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Units b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, p and q stover trading estate, yate, bristol together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures therein. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Units a-h seacroft industrial estate, coal road, seacroft, leeds. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures therein. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Units 1-3 bessemer road, cardiff, together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the north west side of elland road leeds. West yorkshire. Title no. Yk 9717. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land lying to the north west of cheatsey road, byfleet, woking, surrey, title no. Sy 300102. together with the buildings and all fixed plant machinery & fixture thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Units D8, D9, D10/11 stanley green trading estate, cheadle, hulme cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery & fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 apr 1984 Consegnato il 11 mag 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Units D1/D2, d 3/4, D5, D6 and D7 stanley green grading estage, cheadle, hulme, cheshire. Together with the buildings and all fixed plant machinery and fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0