FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED

FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00599245
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED?

    • (3663) /

    Dove si trova FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor Davidson House
    Forbury Square
    RG1 3EU Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 ott 2012

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    4 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 set 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 set 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 set 2010

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Aquarium 1-7 King Street Reading Berkshire RG1 2AN in data 09 set 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 set 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mar 2009

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    8 pagine2.34B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    8 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    4 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    26 pagine2.17B

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363a

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GAULT, Jonathan James Leslie
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    Segretario
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    British11059570005
    BRYAN, Frederick George
    21 Millborough Crescent
    SE12 0RR London
    Amministratore
    21 Millborough Crescent
    SE12 0RR London
    EnglandBritish127114690001
    GAULT, Jonathan James Leslie
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    Amministratore
    Chestnut Farm
    Popes Hill
    GL14 1LB Newnham On Severn
    Gloucestershire
    EnglandBritish11059570005
    SCOTT, John
    Malt Cottage
    Ardleigh Road, Dedham
    CO7 6EE Colchester
    Amministratore
    Malt Cottage
    Ardleigh Road, Dedham
    CO7 6EE Colchester
    United KingdomBritish112981200001
    WELLBORNE, John Peter
    Somerden Oast
    Tonbridge Road
    TN8 7AJ Bough Beech
    Kent
    Amministratore
    Somerden Oast
    Tonbridge Road
    TN8 7AJ Bough Beech
    Kent
    British127114680001
    MILNER, Keith
    38 Deep Spinney
    MK40 4QH Biddenham
    Bedfordshire
    Segretario
    38 Deep Spinney
    MK40 4QH Biddenham
    Bedfordshire
    British78429440001
    PATEL, Bihesh
    9 Magnolia Court
    The Mall
    HA3 9UB Harrow
    Middlesex
    Segretario
    9 Magnolia Court
    The Mall
    HA3 9UB Harrow
    Middlesex
    British98979900001
    SAVADIA, Nitin Devchand
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    Segretario
    52 Hillbury Avenue
    Kenton
    HA3 8EW Harrow
    Middlesex
    British14455810001
    ALLAN, Alistair David Wishart
    Sandwood
    Sandy Loan
    EH31 2BH Gullane
    East Lothian
    Amministratore
    Sandwood
    Sandy Loan
    EH31 2BH Gullane
    East Lothian
    United KingdomBritish984960001
    CHAMBERLAIN, Roger Brian
    47 Poplar Avenue
    BN3 8PT Hove
    East Sussex
    Amministratore
    47 Poplar Avenue
    BN3 8PT Hove
    East Sussex
    EnglandBritish87578030001
    GAULT, David Hamilton
    Telegraph House
    North Marden
    PO18 9JX Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Telegraph House
    North Marden
    PO18 9JX Chichester
    West Sussex
    British1886870001
    HARRIS, Diana Jane
    60 Aytoun Road
    G41 5HE Glasgow
    Amministratore
    60 Aytoun Road
    G41 5HE Glasgow
    United KingdomBritish34753120001
    TATTERSALL, John Richard
    51 Cobden Hill
    WD7 7JL Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    51 Cobden Hill
    WD7 7JL Radlett
    Hertfordshire
    British1886890001
    THORNTON, Adrian Heber
    31 Cheyne Row
    SW3 5HW London
    Amministratore
    31 Cheyne Row
    SW3 5HW London
    British218050001
    TRECHMAN, Gavin
    8 Paultons Street
    SW3 5DP London
    Amministratore
    8 Paultons Street
    SW3 5DP London
    British35249390001

    FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 09 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal assignment
    Creato il 23 ago 2007
    Consegnato il 29 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under the agreement for the purchase of debts and includes any discounting allowance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 ago 1999
    Consegnato il 14 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 14 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 1981
    Consegnato il 06 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, together with all fixtures, fixed plant and machinery, all stocks, shares and other securities.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1974
    Consegnato il 18 mar 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital fixed and floating charges (see doc 42 for details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement for further charge
    Creato il 04 feb 1966
    Consegnato il 16 feb 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000
    Brevi particolari
    Floating charge on:. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • L.M. Spalton
    Transazioni
    • 16 feb 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 ago 1965
    Consegnato il 02 set 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15000
    Brevi particolari
    Floating charge on undertaking all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • L.M. Spalton
    Transazioni
    • 02 set 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 06 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FIREMASTER EXTINGUISHER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 dic 2007Inizio dell'amministrazione
    17 mar 2008Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Ellison
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Praticante
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Gareth Wyn Roberts
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks
    Praticante
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks
    2
    DataTipo
    17 mar 2008Inizio della liquidazione
    16 gen 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Ellison
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Praticante
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Gareth Wyn Roberts
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks
    Praticante
    Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berks

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0