MOUNTSFIELD PROPERTIES

MOUNTSFIELD PROPERTIES

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOUNTSFIELD PROPERTIES
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00602264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    • (7011) /

    Dove si trova MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOUNTSFIELD PROPERTIES LIMITED03 apr 195803 apr 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 gen 2011

    Stato del capitale al 18 gen 2011

    • Capitale: GBP 500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Varie

    Memorandum of capital - processed 25/11/08. reducing issd cap from £500 to £1. date of red 10/11/08
    1 pagineMISC

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato

    1 pagineCERT3

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    11 pagineMAR

    Chi sono gli amministratori di MOUNTSFIELD PROPERTIES?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Amministratore
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Amministratore
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Amministratore
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartred Surveyor152497530001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Amministratore
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Amministratore
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Amministratore
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor63986410003
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Amministratore
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    WILSON, Alan James
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    Amministratore
    30 Broxbourne Road
    BR6 0AY Orpington
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant3078220001

    MOUNTSFIELD PROPERTIES ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 21 nov 1977
    Consegnato il 24 nov 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the british land company limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All f/h property 20 norton folgate london E.1 title no ln 217847 together with buildings and all fixed plant and machinery & fixtures.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Limited
    Transazioni
    • 24 nov 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed effecting substitution of security
    Creato il 08 apr 1971
    Consegnato il 13 apr 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £741,774 due from B.L. holdings LTD. To the chargee secured by a charge dated 22/6/65
    Brevi particolari
    Various properties in kent, essex, surrey, middx and london hampshire (see doc 37 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Royal Liver Trustees LTD
    Transazioni
    • 13 apr 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assurance
    Creato il 17 gen 1968
    Consegnato il 25 gen 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing debenture stock of the british land company LTD. Amounting to £3,500,000 secured by a trust deed dated 30/4/62, and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Two factory premises 464, basingstoke rd. Reading berkshire together with landlords fixtures thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 25 gen 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 29 apr 1966
    Consegnato il 06 mag 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of the british land co. LTD. Amounting to £2,489,320 inclusive of £1,826,320 secured by a trust deed dated 30/04/62 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    The property charged by the trust deed dated 30/04/62 (see rider attached to doc 24) factory premises was by bridge road, sydenham, SE26 with landlords fixtures.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 06 mag 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 26 mar 1964
    Consegnato il 08 apr 1964
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £622.320 debenture stock of the british land co LTD.
    Brevi particolari
    Properties charged by trust deed of 30.4.62 with the exception of the properties in the schedule attached to doc 21.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 08 apr 1964Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed supplemental to two trust deeds dated 30.4.62 & 19.10.63, registered pursuant to an order of court dated 13.12.63
    Creato il 30 ott 1963
    Consegnato il 19 dic 1963
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,134 first mortgage debenture stock of the british land company limited
    Brevi particolari
    The properties charged by the said trust deed dated 30/04/62 with the exception of the properties listed in the attached rider together with landlords fixtures thereon (see doc 19).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 19 dic 1963Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed (supplemental to a trust deed dated 20TH april 1962)
    Creato il 19 ott 1962
    Consegnato il 30 ott 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £158866 first mortgage debenture stock of the british land company LTD.
    Brevi particolari
    The property charged by the said trust deed dated 3/th april 1962.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 30 ott 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 30 apr 1962
    Consegnato il 15 mag 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Trust deed for securing £1,000,000 debenture stock of the british land company LTD.
    Brevi particolari
    See doc 14 and schedule attached.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 15 mag 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 03 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0