MOUNTSFIELD PROPERTIES
Panoramica
Nome della società | MOUNTSFIELD PROPERTIES |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 00602264 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MOUNTSFIELD PROPERTIES?
- (7011) /
Dove si trova MOUNTSFIELD PROPERTIES?
Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MOUNTSFIELD PROPERTIES?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MOUNTSFIELD PROPERTIES LIMITED | 03 apr 1958 | 03 apr 1958 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MOUNTSFIELD PROPERTIES?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per MOUNTSFIELD PROPERTIES?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2008 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Varie Memorandum of capital - processed 25/11/08. reducing issd cap from £500 to £1. date of red 10/11/08 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Limitato a Illimitato | 1 pagine | CERT3 | ||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 11 pagine | MAR | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MOUNTSFIELD PROPERTIES?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKPO, Ndiana | Segretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Amministratore | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Segretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||
BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||
BERRY, David Charles | Amministratore | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||
BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartred Surveyor | 152497530001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||
JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||
KALMAN, Stephen Lionel | Amministratore | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||
METLISS, Cyril | Amministratore | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||
RITBLAT, John, Sir | Amministratore | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||
ROBERTS, Graham Charles | Amministratore | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Amministratore | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 63986410003 | ||||
WEBB, Nigel Mark | Amministratore | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 | ||||
WESTON SMITH, John Harry | Amministratore | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||
WILSON, Alan James | Amministratore | 30 Broxbourne Road BR6 0AY Orpington Kent | England | British | Chartered Accountant | 3078220001 |
MOUNTSFIELD PROPERTIES ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creato il 21 nov 1977 Consegnato il 24 nov 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the british land company limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All f/h property 20 norton folgate london E.1 title no ln 217847 together with buildings and all fixed plant and machinery & fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed effecting substitution of security | Creato il 08 apr 1971 Consegnato il 13 apr 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £741,774 due from B.L. holdings LTD. To the chargee secured by a charge dated 22/6/65 | |
Brevi particolari Various properties in kent, essex, surrey, middx and london hampshire (see doc 37 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of assurance | Creato il 17 gen 1968 Consegnato il 25 gen 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing debenture stock of the british land company LTD. Amounting to £3,500,000 secured by a trust deed dated 30/4/62, and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari Two factory premises 464, basingstoke rd. Reading berkshire together with landlords fixtures thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed | Creato il 29 apr 1966 Consegnato il 06 mag 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing debenture stock of the british land co. LTD. Amounting to £2,489,320 inclusive of £1,826,320 secured by a trust deed dated 30/04/62 and deeds supplemental thereto. | |
Brevi particolari The property charged by the trust deed dated 30/04/62 (see rider attached to doc 24) factory premises was by bridge road, sydenham, SE26 with landlords fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 26 mar 1964 Consegnato il 08 apr 1964 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £622.320 debenture stock of the british land co LTD. | |
Brevi particolari Properties charged by trust deed of 30.4.62 with the exception of the properties in the schedule attached to doc 21. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed supplemental to two trust deeds dated 30.4.62 & 19.10.63, registered pursuant to an order of court dated 13.12.63 | Creato il 30 ott 1963 Consegnato il 19 dic 1963 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £45,134 first mortgage debenture stock of the british land company limited | |
Brevi particolari The properties charged by the said trust deed dated 30/04/62 with the exception of the properties listed in the attached rider together with landlords fixtures thereon (see doc 19). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed (supplemental to a trust deed dated 20TH april 1962) | Creato il 19 ott 1962 Consegnato il 30 ott 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £158866 first mortgage debenture stock of the british land company LTD. | |
Brevi particolari The property charged by the said trust deed dated 3/th april 1962. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 30 apr 1962 Consegnato il 15 mag 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Trust deed for securing £1,000,000 debenture stock of the british land company LTD. | |
Brevi particolari See doc 14 and schedule attached. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0