CULVER STREET (TRADING) LTD
Panoramica
Nome della società | CULVER STREET (TRADING) LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00603495 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CULVER STREET (TRADING) LTD?
- Altra vendita al dettaglio non in negozi, bancarelle o mercati (47990) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CULVER STREET (TRADING) LTD?
Indirizzo della sede legale | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CULVER STREET (TRADING) LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HOLTON PARK MANAGEMENT LIMITED | 02 ott 2006 | 02 ott 2006 |
LAY & WHEELER GROUP LIMITED | 24 apr 1995 | 24 apr 1995 |
LAY AND WHEELER LIMITED | 25 apr 1958 | 25 apr 1958 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CULVER STREET (TRADING) LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per CULVER STREET (TRADING) LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 21 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2017 | 20 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2016 | 20 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2015 | 19 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 4 & 5 the Cedars Old Ipswich Road Ardleigh Colchester Essex CO7 7QR a Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD in data 20 ago 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19 | 8 pagine | 4.20 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Gosbecks Park 117 Gosbecks Road Colchester Essex CO2 9JT England | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 32a Crouch Street Colchester Essex CO3 3HH* in data 18 giu 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr John Richard Wheeler il 15 ott 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Chi sono gli amministratori di CULVER STREET (TRADING) LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEELER, John Richard | Amministratore | New Orleans Coast Road West Mersea CO5 8QF Colchester No 2 Essex Great Britain | United Kingdom | British | Wine And Spirit Merchant | 2764100002 | ||||
COWIE, Ewen Ross | Segretario | Thornleigh 145 Maldon Road CO3 3BJ Colchester Essex | British | 48313030001 | ||||||
MOSS, David Laurence | Segretario | 24 Hayward Road KT7 0BE Thames Ditton Surrey | British | 72651460002 | ||||||
SCARFE, Alexander Robert | Segretario | Christmas Cottage The Street CO10 0SG Little Waldingfield Suffolk | British | 99297500002 | ||||||
CASTLE, Beryl Nelley Henriette | Amministratore | Mayfield 2 Hill Street DG2 7AQ Dumfries | British | Management Consultant | 89662660001 | |||||
CHAPMAN, Nigel Albert | Amministratore | Holly Cottage Straight Road Boxted CO4 5QN Colchester Essex | England | British | Wine And Spirit Merchant | 8042270001 | ||||
COWIE, Ewen Ross | Amministratore | Thornleigh 145 Maldon Road CO3 3BJ Colchester Essex | British | Chartered Accountant | 48313030001 | |||||
COWIE, Ewen Ross | Amministratore | Thornleigh 145 Maldon Road CO3 3BJ Colchester Essex | British | Chartered Accountant | 48313030001 | |||||
FERGUSON, Ronald Timothy Newton | Amministratore | Chapel House Woodlands Road Raydon IP7 5LJ Ipswich | British | Wine And Spirit Merchant | 8042300003 | |||||
HOLT, Michael, Sir | Amministratore | The Tower House Bildeston IP7 7ER Suffolk | British | Chartered Accountant | 3147440002 | |||||
LEE, Elizabeth Ann | Amministratore | 12 Alton Drive CO3 3ST Colchester Essex | British | Married Woman | 8042280001 | |||||
PARKINSON, Joseph Edward | Amministratore | Spillway The Gardens Turton BL7 0RZ Bolton | United Kingdom | British | Company Director | 4553470004 | ||||
SKINNER, Amanda Jane | Amministratore | Holly Lodge Farmhouse NR16 2LD Snetterton Norfolk | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 31444980003 | ||||
THOROGOOD, John | Amministratore | Frances Lodge Stratford Road Dedham CO7 6HW Colchester Essex | British | Wine Merchant | 8042290001 | |||||
THOROGOOD, John | Amministratore | Frances Lodge Stratford Road Dedham CO7 6HW Colchester Essex | British | Wine And Spirit Merchant | 8042290001 | |||||
WHEELER, Christine Mary | Amministratore | 10 Alton Drive CO3 3ST Colchester Essex | British | Widow | 8042310001 | |||||
WHEELER, Christine Mary | Amministratore | West Mersea Hall West Mersea CO5 8QD Colchester Essex | British | Married Woman | 8042320001 | |||||
WHEELER, Johnny Blyth | Amministratore | 58 Bear Street Nayland CO6 4HY Colchester | United Kingdom | British | Wine And Spirit Merchant | 185125210002 | ||||
WHEELER, Susan Mary | Amministratore | 1 Church Cottage Church Road Wormingford CO6 3AZ Colchester | British | Personnel Director | 31393070002 |
CULVER STREET (TRADING) LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 29 mar 2008 Consegnato il 18 apr 2008 | In corso | Importo garantito All monies up to a maximum amount of £300,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First fixed charge over all monies from time to time standing to the credit of the charged bank account in the name of the company and over the charged wine stock account in the name of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 22 dic 2006 Consegnato il 12 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 20 lug 2006 Consegnato il 02 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 24 mar 2006 Consegnato il 13 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 gen 2003 Consegnato il 14 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 23 dic 1991 Consegnato il 07 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that piece of land situate at gosbecks road, colchester having a frontage thereto of 90 feet or thereabouts and an area of .704 acres or thereabouts, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 29 set 1988 Consegnato il 20 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 1 pedders close colchester essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 apr 1987 Consegnato il 01 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at gosbecks rd, shrub end, colchester, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 mar 1987 Consegnato il 01 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 2, pedders close, shrub end, colchester, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 27 mar 1987 Consegnato il 30 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge supplemental to a mortgage dated 22/2/73 and to a deed of further charge dated 28/2/86 | |
Brevi particolari F/H unit 2 pedders close shrub end colchester essex l/h premises in gosbecks road colchester essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 29 set 1986 Consegnato il 06 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 2 pedders close shrub end colchester essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of further charge | Creato il 28 feb 1986 Consegnato il 04 mar 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £120,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 22.2.73. | |
Brevi particolari L/H premises in gosbecks road, colchester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 08 mar 1985 Consegnato il 19 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over all the stock of wine of every kind, including port wine, sherry wine and vermouth, now or may from time to time owned by the company, together with all book or other detbs arising out of the sale of the said stock. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 set 1983 Consegnato il 08 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 6 culver street west colchester, essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 22 feb 1973 Consegnato il 26 feb 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £44,000 all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land, gosbecks road, colechester, essex, comprised in lease dated 29/6/1962. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CULVER STREET (TRADING) LTD ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0