CULVER STREET (TRADING) LTD

CULVER STREET (TRADING) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCULVER STREET (TRADING) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00603495
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CULVER STREET (TRADING) LTD?

    • Altra vendita al dettaglio non in negozi, bancarelle o mercati (47990) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CULVER STREET (TRADING) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Town Wall House
    Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CULVER STREET (TRADING) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOLTON PARK MANAGEMENT LIMITED02 ott 200602 ott 2006
    LAY & WHEELER GROUP LIMITED24 apr 199524 apr 1995
    LAY AND WHEELER LIMITED25 apr 195825 apr 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di CULVER STREET (TRADING) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per CULVER STREET (TRADING) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2017

    20 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2016

    20 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 lug 2015

    19 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 & 5 the Cedars Old Ipswich Road Ardleigh Colchester Essex CO7 7QR a Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD in data 20 ago 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    8 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 31 lug 2014

    LRESEX

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2014

    Stato del capitale al 25 apr 2014

    • Capitale: GBP 3,494,561
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Gosbecks Park 117 Gosbecks Road Colchester Essex CO2 9JT England

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 32a Crouch Street Colchester Essex CO3 3HH* in data 18 giu 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Richard Wheeler il 15 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    23 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di CULVER STREET (TRADING) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHEELER, John Richard
    New Orleans
    Coast Road West Mersea
    CO5 8QF Colchester
    No 2
    Essex
    Great Britain
    Amministratore
    New Orleans
    Coast Road West Mersea
    CO5 8QF Colchester
    No 2
    Essex
    Great Britain
    United KingdomBritishWine And Spirit Merchant2764100002
    COWIE, Ewen Ross
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    Segretario
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    British48313030001
    MOSS, David Laurence
    24 Hayward Road
    KT7 0BE Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    24 Hayward Road
    KT7 0BE Thames Ditton
    Surrey
    British72651460002
    SCARFE, Alexander Robert
    Christmas Cottage
    The Street
    CO10 0SG Little Waldingfield
    Suffolk
    Segretario
    Christmas Cottage
    The Street
    CO10 0SG Little Waldingfield
    Suffolk
    British99297500002
    CASTLE, Beryl Nelley Henriette
    Mayfield 2 Hill Street
    DG2 7AQ Dumfries
    Amministratore
    Mayfield 2 Hill Street
    DG2 7AQ Dumfries
    BritishManagement Consultant89662660001
    CHAPMAN, Nigel Albert
    Holly Cottage Straight Road
    Boxted
    CO4 5QN Colchester
    Essex
    Amministratore
    Holly Cottage Straight Road
    Boxted
    CO4 5QN Colchester
    Essex
    EnglandBritishWine And Spirit Merchant8042270001
    COWIE, Ewen Ross
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    BritishChartered Accountant48313030001
    COWIE, Ewen Ross
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Thornleigh 145 Maldon Road
    CO3 3BJ Colchester
    Essex
    BritishChartered Accountant48313030001
    FERGUSON, Ronald Timothy Newton
    Chapel House Woodlands Road
    Raydon
    IP7 5LJ Ipswich
    Amministratore
    Chapel House Woodlands Road
    Raydon
    IP7 5LJ Ipswich
    BritishWine And Spirit Merchant8042300003
    HOLT, Michael, Sir
    The Tower House
    Bildeston
    IP7 7ER Suffolk
    Amministratore
    The Tower House
    Bildeston
    IP7 7ER Suffolk
    BritishChartered Accountant3147440002
    LEE, Elizabeth Ann
    12 Alton Drive
    CO3 3ST Colchester
    Essex
    Amministratore
    12 Alton Drive
    CO3 3ST Colchester
    Essex
    BritishMarried Woman8042280001
    PARKINSON, Joseph Edward
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    Amministratore
    Spillway
    The Gardens Turton
    BL7 0RZ Bolton
    United KingdomBritishCompany Director4553470004
    SKINNER, Amanda Jane
    Holly Lodge Farmhouse
    NR16 2LD Snetterton
    Norfolk
    Amministratore
    Holly Lodge Farmhouse
    NR16 2LD Snetterton
    Norfolk
    United KingdomBritishChief Operating Officer31444980003
    THOROGOOD, John
    Frances Lodge Stratford Road
    Dedham
    CO7 6HW Colchester
    Essex
    Amministratore
    Frances Lodge Stratford Road
    Dedham
    CO7 6HW Colchester
    Essex
    BritishWine Merchant8042290001
    THOROGOOD, John
    Frances Lodge Stratford Road
    Dedham
    CO7 6HW Colchester
    Essex
    Amministratore
    Frances Lodge Stratford Road
    Dedham
    CO7 6HW Colchester
    Essex
    BritishWine And Spirit Merchant8042290001
    WHEELER, Christine Mary
    10 Alton Drive
    CO3 3ST Colchester
    Essex
    Amministratore
    10 Alton Drive
    CO3 3ST Colchester
    Essex
    BritishWidow8042310001
    WHEELER, Christine Mary
    West Mersea Hall
    West Mersea
    CO5 8QD Colchester
    Essex
    Amministratore
    West Mersea Hall
    West Mersea
    CO5 8QD Colchester
    Essex
    BritishMarried Woman8042320001
    WHEELER, Johnny Blyth
    58 Bear Street
    Nayland
    CO6 4HY Colchester
    Amministratore
    58 Bear Street
    Nayland
    CO6 4HY Colchester
    United KingdomBritishWine And Spirit Merchant185125210002
    WHEELER, Susan Mary
    1 Church Cottage
    Church Road Wormingford
    CO6 3AZ Colchester
    Amministratore
    1 Church Cottage
    Church Road Wormingford
    CO6 3AZ Colchester
    BritishPersonnel Director31393070002

    CULVER STREET (TRADING) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 29 mar 2008
    Consegnato il 18 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies up to a maximum amount of £300,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over all monies from time to time standing to the credit of the charged bank account in the name of the company and over the charged wine stock account in the name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Lay and Wheeler Group Pension and Life Assurance Scheme
    Transazioni
    • 18 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 12 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 lug 2006
    Consegnato il 02 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mar 2006
    Consegnato il 13 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Lease UK Limited (2)
    Transazioni
    • 13 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 14 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1991
    Consegnato il 07 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that piece of land situate at gosbecks road, colchester having a frontage thereto of 90 feet or thereabouts and an area of .704 acres or thereabouts, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 1988
    Consegnato il 20 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 pedders close colchester essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1987
    Consegnato il 01 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at gosbecks rd, shrub end, colchester, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1987
    Consegnato il 01 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2, pedders close, shrub end, colchester, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 mar 1987
    Consegnato il 30 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge supplemental to a mortgage dated 22/2/73 and to a deed of further charge dated 28/2/86
    Brevi particolari
    F/H unit 2 pedders close shrub end colchester essex l/h premises in gosbecks road colchester essex.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 30 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 1986
    Consegnato il 06 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 2 pedders close shrub end colchester essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 28 feb 1986
    Consegnato il 04 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £120,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 22.2.73.
    Brevi particolari
    L/H premises in gosbecks road, colchester.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited.
    Transazioni
    • 04 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 08 mar 1985
    Consegnato il 19 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over all the stock of wine of every kind, including port wine, sherry wine and vermouth, now or may from time to time owned by the company, together with all book or other detbs arising out of the sale of the said stock.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 set 1983
    Consegnato il 08 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 6 culver street west colchester, essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 28 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 22 feb 1973
    Consegnato il 26 feb 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £44,000 all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land, gosbecks road, colechester, essex, comprised in lease dated 29/6/1962.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company LTD.
    Transazioni
    • 26 feb 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 21 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CULVER STREET (TRADING) LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 mag 2018Data di scioglimento
    31 lug 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Anthony Murphy
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Praticante
    Chantrey Vellacott Dfk
    Russell Square House
    WC1B 5LF 10-12 Russell Square
    London
    Lee De'Ath
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex
    Praticante
    Town Wall House Balkerne Hill
    CO3 3AD Colchester
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0