TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED

TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00606325
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. (25990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Bramble Way
    Somercotes
    DE55 4RH Alfreton
    Derbyshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRAC BAKER LIMITED09 feb 200509 feb 2005
    BAKER AND BIRCH LIMITED16 giu 195816 giu 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Miss Amanda Balog Sanders come amministratore in data 04 gen 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Robert Lowson come amministratore in data 22 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Kaplan come segretario in data 13 gen 2023

    1 pagineTM02

    Notifica di Chromalloy Uk Holdings Limited come persona con controllo significativo il 17 ott 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione di Trac Group Limited come persona con controllo significativo il 17 ott 2022

    1 paginePSC07

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Clover Nook Road Cotes Park Industrial Estate Somercotes Alfreton DE55 4RF England a 3 Bramble Way Somercotes Alfreton Derbyshire DE55 4RH in data 28 set 2022

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Irfan Mahomed come amministratore in data 05 ago 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Derek Alexander Gartshore come amministratore in data 05 ago 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    24 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Derek Alexander Gartshore il 10 mag 2021

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Derek Alexander Gartshore come amministratore in data 10 mag 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark David Hamilton come amministratore in data 10 mag 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Nelsons Sterne House Lodge Lane Derby DE1 3WD

    1 pagineAD03

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    22 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Trac Group Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Soddisfazione dell'onere 006063250007 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANDERS, Amanda Balog
    Blaisdell Road
    10962 Orangeburg
    330
    New York
    United States
    Segretario
    Blaisdell Road
    10962 Orangeburg
    330
    New York
    United States
    194712770001
    MAHOMED, Irfan Harun Ayub
    Cotes Park Industrial Estate
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    10 Clover Nook Road
    England
    Amministratore
    Cotes Park Industrial Estate
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    10 Clover Nook Road
    England
    EnglandBritish298829300001
    SANDERS, Amanda Balog
    Rca Boulevard
    33410 Palm Beach Gardens
    4100
    Florida
    United States
    Amministratore
    Rca Boulevard
    33410 Palm Beach Gardens
    4100
    Florida
    United States
    United StatesAmerican305008180001
    BAKER, Martin John
    74 The Woodlands
    DE73 8DQ Melbourne
    Derbyshire
    Segretario
    74 The Woodlands
    DE73 8DQ Melbourne
    Derbyshire
    British102253780001
    BAKER, Raymond
    Ledmore 21 Weston Road
    Aston On Trent
    DE72 2AS Derby
    Derbyshire
    Segretario
    Ledmore 21 Weston Road
    Aston On Trent
    DE72 2AS Derby
    Derbyshire
    British15744920001
    GOLDEN, Martin Neil
    12 The Celandines
    Wombourne
    WV5 8HZ Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    12 The Celandines
    Wombourne
    WV5 8HZ Wolverhampton
    West Midlands
    British105155470001
    KAPLAN, David
    c/o Nelsons
    Lodge Lane
    DE1 3WD Derby
    Sterne House
    England
    Segretario
    c/o Nelsons
    Lodge Lane
    DE1 3WD Derby
    Sterne House
    England
    194703020001
    ROBINSON, Leigh Anthony
    Blacklands Farm
    Chester Road
    WS9 0LT Aldridge
    West Midlands
    Segretario
    Blacklands Farm
    Chester Road
    WS9 0LT Aldridge
    West Midlands
    British29969000003
    ADAMS, John Archibald
    Primrose Cottage
    Tong Norton
    TF11 8PZ Shifnal
    Shropshire
    Amministratore
    Primrose Cottage
    Tong Norton
    TF11 8PZ Shifnal
    Shropshire
    EnglandBritish86842620002
    BAKER, Adrian James
    Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 7GR Derby
    Willow Cottage
    Derbyshire
    Amministratore
    Barrow Lane
    Swarkestone
    DE73 7GR Derby
    Willow Cottage
    Derbyshire
    United KingdomBritish129224540001
    BAKER, Derek James
    127 The Woodlands
    Melbourne
    DE73 1DQ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    127 The Woodlands
    Melbourne
    DE73 1DQ Derby
    Derbyshire
    British15744940001
    BAKER, Martin John
    74 The Woodlands
    DE73 8DQ Melbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    74 The Woodlands
    DE73 8DQ Melbourne
    Derbyshire
    British102253780001
    BAKER, Raymond
    Ledmore 21 Weston Road
    Aston On Trent
    DE72 2AS Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Ledmore 21 Weston Road
    Aston On Trent
    DE72 2AS Derby
    Derbyshire
    British15744920001
    BOLTON, Mark Robert
    Clovernook Road
    Q
    DE55 4RF Alfreton
    10
    Derbyshire
    Amministratore
    Clovernook Road
    Q
    DE55 4RF Alfreton
    10
    Derbyshire
    EnglandBritish166140000001
    CROCKER, Robert James
    The Old Post Office
    Bentlawnt
    SY5 0ES Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    The Old Post Office
    Bentlawnt
    SY5 0ES Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritish105710140001
    DAVIES, Andrew
    Islington Gates
    Fleet Street
    B3 1JL Birmingham
    Apartment 214
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Islington Gates
    Fleet Street
    B3 1JL Birmingham
    Apartment 214
    West Midlands
    England
    EnglandBritish167775130001
    GARTSHORE, Derek Alexander
    Kelvin Campus, West Of Scotland Science Park
    Maryhill Road
    G20 0SP Glasgow
    C/O Turbine Services Limited Venture Building,
    Lanarkshire
    Scotland
    Amministratore
    Kelvin Campus, West Of Scotland Science Park
    Maryhill Road
    G20 0SP Glasgow
    C/O Turbine Services Limited Venture Building,
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish205330860001
    HAMILTON, Mark David
    c/o Turbine Services Limited
    Kelvin Campus
    West Of Scotland Science Park
    G20 0SP Glasgow
    Venture Building
    Scotland
    Amministratore
    c/o Turbine Services Limited
    Kelvin Campus
    West Of Scotland Science Park
    G20 0SP Glasgow
    Venture Building
    Scotland
    ScotlandBritish67851470001
    JERRAM, Paul Anthony
    Cotes Park Industrial Estate
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    10
    England
    Amministratore
    Cotes Park Industrial Estate
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    10
    England
    EnglandBritish245255990001
    KAPLAN, David
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    Amministratore
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    United KingdomBritish211234020001
    KORYTKO, Duane Anthony
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    Amministratore
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    EnglandUsa194694610001
    KOTHARI, Rahul
    Sawgrass Corporate Parkway
    Suite 210b
    Sunrise
    440
    Florida 33325
    United States
    Amministratore
    Sawgrass Corporate Parkway
    Suite 210b
    Sunrise
    440
    Florida 33325
    United States
    UsaCanadian183628100001
    LOWSON, Steven Robert
    Suite 880
    Tampa
    Florida
    3000 Bayport Drive
    33607
    United States
    Amministratore
    Suite 880
    Tampa
    Florida
    3000 Bayport Drive
    33607
    United States
    United StatesAmerican183633140001
    OXLEY, Gladys Eunice
    18 Melton Avenue
    Melbourne
    DE73 1FP Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    18 Melton Avenue
    Melbourne
    DE73 1FP Derby
    Derbyshire
    British15744930001
    ROBINSON, Leigh Anthony
    Blacklands Farm
    Chester Road
    WS9 0LT Aldridge
    West Midlands
    Amministratore
    Blacklands Farm
    Chester Road
    WS9 0LT Aldridge
    West Midlands
    EnglandBritish29969000003
    WHITE, Paul
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    Amministratore
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    United KingdomBritish211233580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Clover Nook Industrial Park
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    3 Bramble Way
    Derbyshire
    England
    17 ott 2022
    Clover Nook Industrial Park
    Somercotes
    DE55 4RF Alfreton
    3 Bramble Way
    Derbyshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06440664
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    England
    06 apr 2016
    Marshfield Bank
    CW2 8UY Crewe
    9a
    England
    Forma giuridicaPrivate Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04441988
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    TRAC PRECISION ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2019
    Consegnato il 04 giu 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 04 giu 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 14 nov 2008
    Consegnato il 15 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The equipment being: caltri 2000, 5.0020131. tos kurim 21, 2175218. jones & shipman 540L, B076121. For details of other chattels mortgaged please refer to form 395. see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 01 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transazioni
    • 01 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 gen 2005
    Consegnato il 14 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 dic 2004
    Consegnato il 20 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 mag 1999
    Consegnato il 04 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a plot 1 (iv) pride park derby. T/no DY281086.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0