D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00610733
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DEVELOPMENT SECURITIES DEVELOPMENTS LIMITED26 ott 199326 ott 1993
    CLAYFORM DEVELOPMENTS LIMITED22 ott 198722 ott 1987
    ELYSTAN DEVELOPMENTS LIMITED04 set 195804 set 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 95 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 96 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 97 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    19 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di James Simon Hesketh come amministratore

    5 pagineRP04TM01

    Cessazione della carica di James Simon Hesketh come amministratore in data 08 ago 2019

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    09 set 2019Clarification A second filed TM01 was registered on 09/09/2019.

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 28 feb 2019 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 28 feb 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Bradley David Cassels come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 28 feb 2017

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 feb 2016

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Charles Julian Barwick come amministratore in data 07 set 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mar 2016

    Stato del capitale al 22 mar 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Michael Henry Marx come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Upton come amministratore in data 08 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Bradley David Cassels come amministratore in data 08 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di James Simon Hesketh come amministratore in data 29 gen 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Charles Julian Barwick il 09 nov 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    194325750001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish41925000005
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish72888710004
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Segretario
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    British8606990001
    CROMPTON, Rita Mary
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    Segretario
    36 Priory Avenue
    N8 7RN London
    British4779150001
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Segretario
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158442850001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190659730001
    BARWICK, Charles Julian
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish3818640003
    BODIE, Anthony Ellyah
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    Amministratore
    112 Clifton Hill
    NW8 OJS London
    British34902790002
    BRAYSHAW, Martin John
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    87 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritish8606990001
    BURLETSON, Bryan Richard
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Farmhouse
    Templecombe
    RG9 3HP Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish57633110005
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish130724370005
    CHATTERJEE, Vivienne Teresa
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    Amministratore
    18 Belsize Crescent
    NW3 5QU London
    British9092320001
    CHEER, Bruce Baxter
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    10 Kilmiston House
    TW17 9ES Shepperton
    Middlesex
    British66762930001
    DOWLING, Brian Sidney Preston
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    Amministratore
    Crest House
    Silver Street Goffs Oak
    EN7 5JE Cheshunt
    British36851910001
    GEE, Peter Peregrine Simpson
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Rowells Lodge Ayston Road
    Ridlington
    LE15 9AH Oakham
    Leicestershire
    British68168890001
    HESKETH, James Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish124650200001
    LANDAU, Martin Richard
    Le Schuylkill
    19 Boulevard De Suisse
    MC98000 Monaco
    Monaco
    Amministratore
    Le Schuylkill
    19 Boulevard De Suisse
    MC98000 Monaco
    Monaco
    MonacoBritish731130002
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    PEARSE, Raymond Henry
    79 The Green
    KT17 3JX Ewell
    Surrey
    Amministratore
    79 The Green
    KT17 3JX Ewell
    Surrey
    United KingdomBritish41761870001
    PROTHERO, Graham
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    Amministratore
    Bracken Lane
    RH20 3HR Storrington
    Three Gables
    West Sussex
    United KingdomBritish134427450001
    VAUGHAN, Steven Mark
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    Amministratore
    16 Kittiwake Close
    Woodley
    RG5 4UF Reading
    Berkshire
    British9092330001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    Amministratore
    3 Bayliss Road
    Wargrave
    RG10 8DR Reading
    Berkshire
    British4779170001

    Chi sono le persone con controllo significativo di D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02850465
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    D S PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of partnership interest
    Creato il 25 giu 2010
    Consegnato il 05 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the partnership share. Partnership share means the existing or future interest including any income, offer, right or benefit.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and development securities (no. 1) limited (as borrower) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold properties k/a 209-211 high street bangor, 52 and 54 bebington road wirral new ferry, 16-16A high street newhaven, 3 and 5 church street wilmslow and heath town (or crossways) shopping centre deans road wolverhampton t/n WA701331,MS118386,ESX86619,CH222953,WM400955. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 dic 1995
    Consegnato il 20 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or by development securities estates PLC or by development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various properties specified on form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 feb 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 1995
    Consegnato il 04 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or development securities estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sutherland house brighton road sutton l/b of sutton t/no SGL15039.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 ago 1995
    Consegnato il 04 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or development securities estates PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St nicholas house st nicholas way sutton l/b of sutton t/no SGL18986.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 30 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sutherland house brighton road sutton london borough of sutton t/n SGL15039.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1994
    Consegnato il 30 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or development securities PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St nicholas house st nicholas road sutton london borough of sutton t/n sgl 18986.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee ) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    By way of first floating charge with the payment to the security agent as trustee for the beneficiaries of the secured obligations the whole of its undertaking property rights and assets both present and future and wheresoever situate.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as heath town shopping centre deans road wolverhampton west midlands.t/no.WM400955. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 3 and 5 church street wilmslow cheshire.t/no.CH222953. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined)under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 75 widnes road widnes cheshire.t/no.CH212592. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 5 watergate street whitchurch shropshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as bredwood arcade whitchurch shropshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 52 & 54 bebington road new ferry wirral merseyside.t/no.MS118386. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 16/16A high street newhaven east sussex.t/no.ESX86619. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 209/211 high street bangor gwynedd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that l/h property k/as the austin trading estate (on the north and north east sides of hornhouse lane and on the south east side of south boundary road kirkby) knowsley merseyside.t/nos.MS102296 and MS102297. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 10 high street neston cheshire.t/no.CH252473. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as the nelson bulkeley square llangefni wales.t/no.WA571332. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 115 king street knutsford cheshire.t/no.CH186749. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 79 king street knutsford macclesfield cheshire.t/no.CH141067. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 8/10 abergele road colwyn bay clwyd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined)to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee)to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as unit 4 grosvenor court foregate street chester cheshire.t/no.CH312044. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent)or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 9 wrawby street brigg humberside. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 gen 1994
    Consegnato il 17 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee as trustee for and on behalf of the beneficiaries (the security agent) or any of the beneficiaries (as defined) under any security document (including the guarantee) to which any obligor is a party
    Brevi particolari
    All that f/h property k/as 237 high street bangor gwynedd wales. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0