CPI WHITE QUILL PRESS LTD

CPI WHITE QUILL PRESS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCPI WHITE QUILL PRESS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00612364
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    8 Springfield Close
    Ovington
    NE42 6EL Prudhoe
    Northumberland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WHITE QUILL PRESS LIMITED(THE)03 ott 195803 ott 1958

    Quali sono gli ultimi bilanci di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Cpi Legal Services Arrow House Luckington Chippenham Wiltshire SN14 6NH England a 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2015

    Stato del capitale al 13 lug 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL

    1 pagineAD04

    Stato del capitale al 01 mag 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Cpi Legal Services Portland House Belmont Business Park Durham DH1 1TW a 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL in data 24 apr 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Francois Jacques Pierre Golicheff come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 lug 2014

    Stato del capitale al 21 lug 2014

    • Capitale: GBP 22,500
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Cpi Legal Services Arrow House Bumpers Way Bumpers Farm Chippenham Wiltshire SN14 6LH England

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* in data 11 mar 2014

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Segretario
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    British93423100001
    ROBSON, Matthew William
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    Amministratore
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Reivers
    Northumberland
    England
    EnglandBritish93423100001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Segretario
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    British14483180001
    TAYLOR, Frances Mary
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    Segretario
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    British10315300001
    BOVARD, Timothy Landon
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    Amministratore
    7 Boulevard Anatole France
    FOREIGN Boulogne
    92100
    France
    British101457350001
    CATTE, Pierre Francois
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    Amministratore
    Bis Rue De La Tour
    75016 Paris
    62
    France
    FranceFrench165234830001
    DEEKS, William John
    30 The Farthings
    TN6 2TW Crowborough
    East Sussex
    Amministratore
    30 The Farthings
    TN6 2TW Crowborough
    East Sussex
    British15060610003
    GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    Amministratore
    Cardiff Road
    RG1 8EX Reading
    Cox & Wyman House
    Berkshire
    FranceFrench146651780001
    GUILLIER TUAL, Natalie
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    Amministratore
    43 Bis Rue Henri Cloppet
    Le Vesinet
    78100
    France
    French103508190001
    HARRIS, Derek John
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    Amministratore
    35 Furze Lane
    CR8 3EJ Purley
    Surrey
    United KingdomBritish14483180001
    HUGHES, Richard
    46 Calluna Drive
    Smallfield
    RH10 3XF Copthorne
    West Sussex
    Amministratore
    46 Calluna Drive
    Smallfield
    RH10 3XF Copthorne
    West Sussex
    British75381890002
    ROBSON, Matthew William
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    Amministratore
    Reivers
    Springfield Close
    NE42 6EL Ovington
    Northumberland
    EnglandBritish93423100001
    SMITH, Clive Ernest Batchelor
    Glebeside Church End
    Ashdon
    CB10 2HG Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Glebeside Church End
    Ashdon
    CB10 2HG Saffron Walden
    Essex
    British15060640001
    TAYLOR, Brian
    19 The Walled Gardens
    KT20 5UR Tadworth Park
    Surrey
    Amministratore
    19 The Walled Gardens
    KT20 5UR Tadworth Park
    Surrey
    British92746470001
    TAYLOR, Frances Mary
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    Amministratore
    The Chantry Rectory Lane
    Brasted
    TN16 1NH Westerham
    Kent
    British10315300001
    TAYLOR, Michael Edward
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Forest Hall Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish10315310003
    TAYLOR, William Edward
    Woodview Inglewood Park
    St Lawrence
    PO38 1UX Ventnor
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Woodview Inglewood Park
    St Lawrence
    PO38 1UX Ventnor
    Isle Of Wight
    British15060620001
    WILLIAMS, Michael Owen
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Fisher Green
    Binfield
    RG42 4EQ Bracknell
    1
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish198947630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cpi Uk Management Company Ltd
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    Portland House
    England
    06 apr 2016
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    Portland House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompaniesact 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione2859682
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CPI WHITE QUILL PRESS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory guarantee & debenture
    Creato il 10 dic 2009
    Consegnato il 19 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, Paris Branch as Security Agent and as Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 19 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 12 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,Paris Branch,as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 12 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Confirmatory charge
    Creato il 06 ott 1989
    Consegnato il 19 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property and assets of the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 apr 1986
    Consegnato il 08 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 31/1/73 on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    A specific charge over the benefit of all book & other debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 gen 1973
    Consegnato il 16 feb 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises at 25 water way mitchan morton undertaking and goodwill all property and assets present and future by way of floating charge & fixed charge (see doc 44).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0