CPI WHITE QUILL PRESS LTD
Panoramica
| Nome della società | CPI WHITE QUILL PRESS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00612364 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Indirizzo della sede legale | 8 Springfield Close Ovington NE42 6EL Prudhoe Northumberland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WHITE QUILL PRESS LIMITED(THE) | 03 ott 1958 | 03 ott 1958 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2017 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2017 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Cpi Legal Services Arrow House Luckington Chippenham Wiltshire SN14 6NH England a 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Stato del capitale al 01 mag 2015
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Cpi Legal Services Portland House Belmont Business Park Durham DH1 1TW a 8 Springfield Close Ovington Prudhoe Northumberland NE42 6EL in data 24 apr 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francois Jacques Pierre Golicheff come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Cpi Legal Services Arrow House Bumpers Way Bumpers Farm Chippenham Wiltshire SN14 6LH England | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Cox & Wyman House Cardiff Road Reading Berkshire RG1 8EX* in data 11 mar 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBSON, Matthew William | Segretario | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | British | 93423100001 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Springfield Close NE42 6EL Ovington Reivers Northumberland England | England | British | 93423100001 | |||||
| HARRIS, Derek John | Segretario | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | British | 14483180001 | ||||||
| TAYLOR, Frances Mary | Segretario | The Chantry Rectory Lane Brasted TN16 1NH Westerham Kent | British | 10315300001 | ||||||
| BOVARD, Timothy Landon | Amministratore | 7 Boulevard Anatole France FOREIGN Boulogne 92100 France | British | 101457350001 | ||||||
| CATTE, Pierre Francois | Amministratore | Bis Rue De La Tour 75016 Paris 62 France | France | French | 165234830001 | |||||
| DEEKS, William John | Amministratore | 30 The Farthings TN6 2TW Crowborough East Sussex | British | 15060610003 | ||||||
| GOLICHEFF, Francois Jacques Pierre | Amministratore | Cardiff Road RG1 8EX Reading Cox & Wyman House Berkshire | France | French | 146651780001 | |||||
| GUILLIER TUAL, Natalie | Amministratore | 43 Bis Rue Henri Cloppet Le Vesinet 78100 France | French | 103508190001 | ||||||
| HARRIS, Derek John | Amministratore | 35 Furze Lane CR8 3EJ Purley Surrey | United Kingdom | British | 14483180001 | |||||
| HUGHES, Richard | Amministratore | 46 Calluna Drive Smallfield RH10 3XF Copthorne West Sussex | British | 75381890002 | ||||||
| ROBSON, Matthew William | Amministratore | Reivers Springfield Close NE42 6EL Ovington Northumberland | England | British | 93423100001 | |||||
| SMITH, Clive Ernest Batchelor | Amministratore | Glebeside Church End Ashdon CB10 2HG Saffron Walden Essex | British | 15060640001 | ||||||
| TAYLOR, Brian | Amministratore | 19 The Walled Gardens KT20 5UR Tadworth Park Surrey | British | 92746470001 | ||||||
| TAYLOR, Frances Mary | Amministratore | The Chantry Rectory Lane Brasted TN16 1NH Westerham Kent | British | 10315300001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Edward | Amministratore | Forest Hall Springwood Park TN11 9LZ Tonbridge Kent | England | British | 10315310003 | |||||
| TAYLOR, William Edward | Amministratore | Woodview Inglewood Park St Lawrence PO38 1UX Ventnor Isle Of Wight | British | 15060620001 | ||||||
| WILLIAMS, Michael Owen | Amministratore | Fisher Green Binfield RG42 4EQ Bracknell 1 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 198947630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CPI WHITE QUILL PRESS LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpi Uk Management Company Ltd | 06 apr 2016 | Belmont Business Park DH1 1TW Durham Portland House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CPI WHITE QUILL PRESS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Confirmatory guarantee & debenture | Creato il 10 dic 2009 Consegnato il 19 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 26 lug 2006 Consegnato il 12 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Confirmatory charge | Creato il 06 ott 1989 Consegnato il 19 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property and assets of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 21 apr 1986 Consegnato il 08 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 31/1/73 on any account whatsoever. | |
Brevi particolari A specific charge over the benefit of all book & other debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 31 gen 1973 Consegnato il 16 feb 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold premises at 25 water way mitchan morton undertaking and goodwill all property and assets present and future by way of floating charge & fixed charge (see doc 44). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0