COODE & PARTNERS

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOODE & PARTNERS
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00619356
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COODE & PARTNERS?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COODE & PARTNERS?

    Indirizzo della sede legale
    Wsp House
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COODE & PARTNERS?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COODE & PARTNERS?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COODE & PARTNERS?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2015

    Stato del capitale al 03 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Nabarro Llp 1 South Quay, Victoria Quays Wharf Street Sheffield S2 5SY England a Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF

    1 pagineAD04

    Indirizzo della sede legale modificato da Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF a Wsp House 70 Chancery Lane London WC2A 1AF in data 02 giu 2015

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Issued share capital reduced 07/05/2015
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 apr 2015

    Stato del capitale al 23 apr 2015

    • Capitale: GBP 5,100
    SH01

    Cessazione della carica di Christopher Cole come amministratore in data 20 ott 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2014

    Stato del capitale al 10 apr 2014

    • Capitale: GBP 5,100
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Nomina di Andrew Christopher John Noble come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Graham Bisset come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Bisset come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Graham Ferguson Bisset il 01 mar 2013

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Cole il 01 mar 2013

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Mr Graham Ferguson Bisset come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di COODE & PARTNERS?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NOBLE, Andrew Christopher John
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    United Kingdom
    United KingdomBritish192017410001
    BISSET, Graham Ferguson
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Segretario
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    British56857830001
    MARTIN, Christopher Charles
    Ground Floor Flat 27 Garfield Road
    Chingford
    E4 7DG London
    Segretario
    Ground Floor Flat 27 Garfield Road
    Chingford
    E4 7DG London
    British43568800001
    O SULLIVAN, Christopher Shaun
    97 High Street
    Wheatley
    OX33 1XP Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    97 High Street
    Wheatley
    OX33 1XP Oxford
    Oxfordshire
    British44060060001
    PAUL, Malcolm Stephen
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    Segretario
    Kimberley 4 Grove Shaw
    Kingswood Court
    KT20 6QL Tadworth
    Surrey
    British3865030001
    SHERIDAN, Michael Kenneth
    Oakways
    Tubbs Lane, Highclere
    RG20 9PQ Newbury
    Berkshire
    Segretario
    Oakways
    Tubbs Lane, Highclere
    RG20 9PQ Newbury
    Berkshire
    British66376420001
    SLAUGHTER, Colin Duncan
    Roxburgh Cottage
    Stavenden Lane
    TN17 2AN Sissinghurst Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Roxburgh Cottage
    Stavenden Lane
    TN17 2AN Sissinghurst Cranbrook
    Kent
    British2592980001
    BISSET, Graham Ferguson
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    ScotlandBritish56857830001
    BRIGGS, Michael George
    Red Cottage
    Swan Lane
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    Red Cottage
    Swan Lane
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British2592990002
    BURNS, John Roger Stewart
    5 Eastbourne Avenue
    SO15 5HU Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    5 Eastbourne Avenue
    SO15 5HU Southampton
    Hampshire
    British2593020001
    COLE, Christopher
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    Amministratore
    70 Chancery Lane
    WC2A 1AF London
    Wsp House
    EnglandBritish39376270004
    GILL, Peter Richard
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    30 Sheen Common Drive
    TW10 5BN Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish35996320004
    HALLETT, David Keith
    176 Overdale
    KT21 1PE Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    176 Overdale
    KT21 1PE Ashtead
    Surrey
    British2593030001
    HODGKINSON, William George
    Orchard Lea
    20 Coldharbour Close
    RG9 1QF Hanley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Orchard Lea
    20 Coldharbour Close
    RG9 1QF Hanley On Thames
    Oxfordshire
    British20774120002
    HUGHES, Lionel Maurice
    Oak Hillcottage 15 Little Oak Road
    SO16 7EN Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Oak Hillcottage 15 Little Oak Road
    SO16 7EN Southampton
    Hampshire
    British2595440001
    PAUL, Malcolm Stephen
    Staplefield Road
    Cuckfield
    RH17 5HY Haywards Heath
    Henmead Hall
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Staplefield Road
    Cuckfield
    RH17 5HY Haywards Heath
    Henmead Hall
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish3865030002
    PICKERING, Hugh Antony
    551 Bitterne Road
    Bitterne
    SO15 5EQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    551 Bitterne Road
    Bitterne
    SO15 5EQ Southampton
    Hampshire
    British2593010001
    SLAUGHTER, Colin Duncan
    Roxburgh Cottage
    Stavenden Lane
    TN17 2AN Sissinghurst Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Roxburgh Cottage
    Stavenden Lane
    TN17 2AN Sissinghurst Cranbrook
    Kent
    British2592980001

    COODE & PARTNERS ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 apr 1997
    Consegnato il 17 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 apr 1996
    Consegnato il 09 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 ott 1990
    Consegnato il 22 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or coode blizard limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 1982
    Consegnato il 23 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts with all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 23 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0