TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED

TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00623242
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THISTLE BLOOMSBURY PARK LIMITED 13 gen 200313 gen 2003
    LPH GRAND LIMITED08 feb 198508 feb 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2014

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 mar 2014

    8 pagine4.68

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2013

    Stato del capitale al 05 giu 2013

    • Capitale: GBP 500
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom

    1 pagineAD02

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    legacy

    4 pagineMG02

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 07 gen 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 03 apr 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2010

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 01 set 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 19 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Clive Edward Bush il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Segretario
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    British74265400001
    BUSH, Clive Edward
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    EnglandBritish62062860002
    MOHARM, Cheryl Frances
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritish74265400003
    ZAKAY, Eddie
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    Amministratore
    103 Wigmore Street
    W1U 1QS London
    Nations House
    United Kingdom
    United KingdomBritish8477470004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Segretario
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    British150020002
    HOWDEN, Graham
    56 Tinshill Road
    LS16 7DU Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    56 Tinshill Road
    LS16 7DU Leeds
    West Yorkshire
    British116608840001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bordley
    Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440001
    BOYLE, Andrew Iain
    28 Woodhill Rise
    Cookridge
    LS16 7DB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    28 Woodhill Rise
    Cookridge
    LS16 7DB Leeds
    West Yorkshire
    British58475810001
    CATTERMOLE, Ian Kendall
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Spindlewood
    Coppins Close
    HP4 3NZ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British82666030001
    DURANT, Ian Charles
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    Amministratore
    57 The Avenue
    Kew
    TW9 2AL Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish150020002
    FAIRLEY, Neil Duff
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    72 Carr Road
    Calverley
    LS28 5RH Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish78198900001
    MOK, Rayman
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    Amministratore
    PO BOX 44790
    101 Buckingham Palace Road
    SW1W 0WA London
    Singaporean101871540001
    NEWSOME, Gillian Anne
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Layton Lane
    Rawdon
    LS19 6RQ Leeds
    West Yorkshire
    British70404230001
    O'MAHONEY, Michael
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    44 Beechcroft Manor
    KT13 9NZ Weybridge
    Surrey
    British84990810001
    PAWSON, Kenneth Vernon Frank
    Haggas Hall
    Weeton
    LS17 0BH Leeds
    North Yorkshire
    Amministratore
    Haggas Hall
    Weeton
    LS17 0BH Leeds
    North Yorkshire
    British3826140001
    PEEL, Robert Edmund Guy
    19a Warwick Avenue
    W9 2PS London
    Amministratore
    19a Warwick Avenue
    W9 2PS London
    EnglandBritish127900001
    PETERSEN, Norbert Paul Gottfried
    81 Burlington Lane
    W4 3ET London
    Amministratore
    81 Burlington Lane
    W4 3ET London
    United KingdomGerman62117390001
    SUTCLIFFE, Hartley William
    3 The Close
    LS23 6BY Boston Spa
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 The Close
    LS23 6BY Boston Spa
    West Yorkshire
    Australian56181650001
    WILDEN, Nichola Jane
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    Amministratore
    12c Elsworthy Terrace
    NW3 3DR London
    EnglandBritish24856300002
    YOUNG, Stephen Gareth
    Greenlands Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6PE Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Greenlands Lee Lane
    Pinkneys Green
    SL6 6PE Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish21273730002
    ZAKAY, Sol
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    Amministratore
    46 Avenue Road
    NW8 6HS London
    United KingdomBritish26053220007

    TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a grand hotel 126 and 128 southampton row and 8 to 10 cosmo place holborn london t/no NGL3488619 and NGL27723 by way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 giu 1997
    Consegnato il 08 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due and payable by the company as joint and several guarantor of all sums due and payable by thistle hotels PLC, under the third supplemental trust deed being £60,000,000 in principal amount of the 7 7/8 per cent. First mortgage debenture stock 2022 (the "new stock") constituted thereby and all premium and interest thereon together with £200,000,000 in principal amount of the 10 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2014 (the "original stock") constituted by a trust deed dated 30TH august 1989 and a second supplemental trust deed dated 3RD november 1989 (the "principal trust deed") together with all premium and interest thereon and all other moneys as provided in the principal trust deed payable by the company pursuant thereto
    Brevi particolari
    Floating charge all undertaking and all property assets and rights present and future wheresoever situate including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 08 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture created by a second supplemental trust deed
    Creato il 03 nov 1989
    Consegnato il 11 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 000 10 3/4% first mortgage debenture stock 2014 ("new stock") of mount charlotte investments PLC together with £100,000,000 10 3/4% first mortgage debenture stock 2014 ("orginal stock") of mount charlote investments PLC together with all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee under the terms and as defined in this deed
    Brevi particolari
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.Cas Trustee
    Transazioni
    • 11 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 31 ott 1989
    Consegnato il 09 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee and or trustees of a trust deed dated 11/7/89
    Brevi particolari
    F/H property k/a the bloomsbury park hotel (formerly the grand hotel) 126 & 128 southampton row, holborn & 8 & 10 cosmo place holborn t/nos ngl 348619 & ngl 2772B & fixtures fittings plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 14 mar 1983
    Consegnato il 16 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £750,000 10 1/2 percent first mortgage debenture stock 2000/05 of rowton hotels PLC and all other monies due secured by a trust deed dated 30TH october 1970
    Brevi particolari
    F/Hold land and premises known as the grand hotel, 126 and 128 southampton row and 8 and 10 cosmo place, holborn, london WC1 with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery title nos. Ngl 27723 and ngl 348619.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 16 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 30 ott 1970
    Consegnato il 19 nov 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For the purpose of securing debenture stock of rowton hotels limited amounting to £700,000
    Brevi particolari
    (A) charged mount pleasant hotel 53 calthorpe street and 27 king's cross road london WC1 together with fixed plant and machinery and fixtures (b) by way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 19 nov 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 04 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 dic 2014Data di scioglimento
    04 mar 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0