TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00623242 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
- Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione
Dove si trova TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THISTLE BLOOMSBURY PARK LIMITED | 13 gen 2003 | 13 gen 2003 |
| LPH GRAND LIMITED | 08 feb 1985 | 08 feb 1985 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 set 2014 | 6 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 mar 2014 | 8 pagine | 4.68 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 4 pagine | MG02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 07 gen 2013 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 03 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mag 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 01 set 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Eddie Zakay il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Clive Edward Bush il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Cheryl Frances Moharm il 01 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOHARM, Cheryl Frances | Segretario | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | British | 74265400001 | ||||||
| BUSH, Clive Edward | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | England | British | 62062860002 | |||||
| MOHARM, Cheryl Frances | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | 74265400003 | |||||
| ZAKAY, Eddie | Amministratore | 103 Wigmore Street W1U 1QS London Nations House United Kingdom | United Kingdom | British | 8477470004 | |||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Segretario | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Segretario | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | 82666030001 | ||||||
| DURANT, Ian Charles | Segretario | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | British | 150020002 | ||||||
| HOWDEN, Graham | Segretario | 56 Tinshill Road LS16 7DU Leeds West Yorkshire | British | 116608840001 | ||||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Amministratore | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| BOYLE, Andrew Iain | Amministratore | 28 Woodhill Rise Cookridge LS16 7DB Leeds West Yorkshire | British | 58475810001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Amministratore | Spindlewood Coppins Close HP4 3NZ Berkhamsted Hertfordshire | British | 82666030001 | ||||||
| DURANT, Ian Charles | Amministratore | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | United Kingdom | British | 150020002 | |||||
| FAIRLEY, Neil Duff | Amministratore | 72 Carr Road Calverley LS28 5RH Leeds West Yorkshire | England | British | 78198900001 | |||||
| MOK, Rayman | Amministratore | PO BOX 44790 101 Buckingham Palace Road SW1W 0WA London | Singaporean | 101871540001 | ||||||
| NEWSOME, Gillian Anne | Amministratore | 15 Layton Lane Rawdon LS19 6RQ Leeds West Yorkshire | British | 70404230001 | ||||||
| O'MAHONEY, Michael | Amministratore | 44 Beechcroft Manor KT13 9NZ Weybridge Surrey | British | 84990810001 | ||||||
| PAWSON, Kenneth Vernon Frank | Amministratore | Haggas Hall Weeton LS17 0BH Leeds North Yorkshire | British | 3826140001 | ||||||
| PEEL, Robert Edmund Guy | Amministratore | 19a Warwick Avenue W9 2PS London | England | British | 127900001 | |||||
| PETERSEN, Norbert Paul Gottfried | Amministratore | 81 Burlington Lane W4 3ET London | United Kingdom | German | 62117390001 | |||||
| SUTCLIFFE, Hartley William | Amministratore | 3 The Close LS23 6BY Boston Spa West Yorkshire | Australian | 56181650001 | ||||||
| WILDEN, Nichola Jane | Amministratore | 12c Elsworthy Terrace NW3 3DR London | England | British | 24856300002 | |||||
| YOUNG, Stephen Gareth | Amministratore | Greenlands Lee Lane Pinkneys Green SL6 6PE Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 21273730002 | |||||
| ZAKAY, Sol | Amministratore | 46 Avenue Road NW8 6HS London | United Kingdom | British | 26053220007 |
TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 28 apr 2005 Consegnato il 07 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the companies and topland group holdings limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land k/a grand hotel 126 and 128 southampton row and 8 to 10 cosmo place holborn london t/no NGL3488619 and NGL27723 by way of fixed charge all moneys standing to the credit of the charged accounts, the benefits in respect of the insurances, all rights under each occupational lease, the benefit of all licences, all rights under the assigned agreements, all shares and related rights. By way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 26 giu 1997 Consegnato il 08 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due and payable by the company as joint and several guarantor of all sums due and payable by thistle hotels PLC, under the third supplemental trust deed being £60,000,000 in principal amount of the 7 7/8 per cent. First mortgage debenture stock 2022 (the "new stock") constituted thereby and all premium and interest thereon together with £200,000,000 in principal amount of the 10 3/4 per cent. First mortgage debenture stock 2014 (the "original stock") constituted by a trust deed dated 30TH august 1989 and a second supplemental trust deed dated 3RD november 1989 (the "principal trust deed") together with all premium and interest thereon and all other moneys as provided in the principal trust deed payable by the company pursuant thereto | |
Brevi particolari Floating charge all undertaking and all property assets and rights present and future wheresoever situate including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture created by a second supplemental trust deed | Creato il 03 nov 1989 Consegnato il 11 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £100,000 000 10 3/4% first mortgage debenture stock 2014 ("new stock") of mount charlotte investments PLC together with £100,000,000 10 3/4% first mortgage debenture stock 2014 ("orginal stock") of mount charlote investments PLC together with all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as trustee under the terms and as defined in this deed | |
Brevi particolari Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental trust deed | Creato il 31 ott 1989 Consegnato il 09 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee and or trustees of a trust deed dated 11/7/89 | |
Brevi particolari F/H property k/a the bloomsbury park hotel (formerly the grand hotel) 126 & 128 southampton row, holborn & 8 & 10 cosmo place holborn t/nos ngl 348619 & ngl 2772B & fixtures fittings plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and substitution | Creato il 14 mar 1983 Consegnato il 16 mar 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £750,000 10 1/2 percent first mortgage debenture stock 2000/05 of rowton hotels PLC and all other monies due secured by a trust deed dated 30TH october 1970 | |
Brevi particolari F/Hold land and premises known as the grand hotel, 126 and 128 southampton row and 8 and 10 cosmo place, holborn, london WC1 with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery title nos. Ngl 27723 and ngl 348619. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 30 ott 1970 Consegnato il 19 nov 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For the purpose of securing debenture stock of rowton hotels limited amounting to £700,000 | |
Brevi particolari (A) charged mount pleasant hotel 53 calthorpe street and 27 king's cross road london WC1 together with fixed plant and machinery and fixtures (b) by way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
TOPLAND HOTELS (BLOOMSBURY PARK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0