A.R.DAUNT & CO LIMITED

A.R.DAUNT & CO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàA.R.DAUNT & CO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00624526
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    P & H House
    Davigdor Road
    BN3 1RE Hove
    East Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al06 apr 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 07 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 06 apr 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 07 apr 2012

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 02 apr 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Mr David Scudder come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Mckelvie come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2010

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di David Buchan come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Etherington il 09 mar 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Julian St John Streeter il 06 mar 2008

    1 pagineCH01

    Bilancio redatto al 04 apr 2009

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di A.R.DAUNT & CO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCUDDER, David
    P & H House
    Davigdor Road
    BN3 1RE Hove
    East Sussex
    Segretario
    P & H House
    Davigdor Road
    BN3 1RE Hove
    East Sussex
    165170040001
    ETHERINGTON, Christopher
    P & H House
    Davigdor Road
    BN3 1RE Hove
    East Sussex
    Amministratore
    P & H House
    Davigdor Road
    BN3 1RE Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish113997090003
    MOXON, Jonathan David
    Sandy Burrows
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Sandy Burrows
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    EnglandBritish68503410002
    STREETER, Julian St John
    Headley Road
    Grayshott
    GU26 6JG Hindhead
    Longacre
    Amministratore
    Headley Road
    Grayshott
    GU26 6JG Hindhead
    Longacre
    United KingdomBritish90334190003
    BLATCHFORD, Eric David
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    Segretario
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    British52322990002
    BUCHAN, David
    21 Lawrence Road
    BN3 5QA Hove
    East Sussex
    Segretario
    21 Lawrence Road
    BN3 5QA Hove
    East Sussex
    British29822230002
    DAUNT, Nicholas Mark
    Waters Edge
    Boat Lane, Hoveringham
    NG14 7JP Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Waters Edge
    Boat Lane, Hoveringham
    NG14 7JP Nottingham
    Nottinghamshire
    British5799040002
    FURNESS, Lee Scott
    Hillam Hall
    Chapel Street, Hillam
    LS25 5HP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Hillam Hall
    Chapel Street, Hillam
    LS25 5HP Leeds
    West Yorkshire
    British36538140003
    MCKELVIE, Andrew Laurence
    110 Osborne Road
    BN1 6LU Brighton
    East Sussex
    Segretario
    110 Osborne Road
    BN1 6LU Brighton
    East Sussex
    British60126680002
    RICHARDSON, Florence Dorothie Ann
    18 Joyce Avenue
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    Segretario
    18 Joyce Avenue
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    Irish49091210001
    STRINGER, Paul Stephen
    18 Glebe Field Drive
    LS22 6WG Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    18 Glebe Field Drive
    LS22 6WG Wetherby
    West Yorkshire
    British2617020001
    TOMLINSON, Nicholas Clifton
    11 Vicarwood Avenue
    DE22 1BX Darley Abbey
    Derbyshire
    Segretario
    11 Vicarwood Avenue
    DE22 1BX Darley Abbey
    Derbyshire
    British73982840001
    VAUX, Shirley Patricia
    Avalon Cliff Hill Lane
    Aslockton
    NG13 9AP Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Avalon Cliff Hill Lane
    Aslockton
    NG13 9AP Nottingham
    Nottinghamshire
    British5799010001
    ALLMAN, Denis Louis
    Troutbeck 4 Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Troutbeck 4 Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Irish52332630001
    BLATCHFORD, Eric David
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    Amministratore
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    British52322990002
    BUCHAN, David
    21 Lawrence Road
    BN3 5QA Hove
    East Sussex
    Amministratore
    21 Lawrence Road
    BN3 5QA Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish29822230002
    CRAWFORD, Leo John Anthony
    Rivendell 21 Offington Court
    Sutton
    13 Dublin
    13
    Ireland
    Amministratore
    Rivendell 21 Offington Court
    Sutton
    13 Dublin
    13
    Ireland
    Irish63846840001
    DAUNT, Arthur Nicholas
    Pastures Farm The Drift
    Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Pastures Farm The Drift
    Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    British5799020001
    DAUNT, Beatrice Anne
    Pastures Farm The Drift
    Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Pastures Farm The Drift
    Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    British5799030001
    DAUNT, Nicholas Mark
    Waters Edge
    Boat Lane, Hoveringham
    NG14 7JP Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Waters Edge
    Boat Lane, Hoveringham
    NG14 7JP Nottingham
    Nottinghamshire
    British5799040002
    FURNESS, Lee Scott
    Hillam Hall
    Chapel Street, Hillam
    LS25 5HP Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hillam Hall
    Chapel Street, Hillam
    LS25 5HP Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish36538140003
    GIBSON, Peter Alan
    24 Croft Avenue
    NG14 4SR Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    24 Croft Avenue
    NG14 4SR Mansfield
    Nottinghamshire
    British89997340001
    GIBSON, Peter Alan
    24 Croft Avenue
    NG14 4SR Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    24 Croft Avenue
    NG14 4SR Mansfield
    Nottinghamshire
    British89997340001
    JEFFERSON, George Leslie
    1 Elm Close
    Long Bennington
    NG23 5EZ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    1 Elm Close
    Long Bennington
    NG23 5EZ Newark
    Nottinghamshire
    British5799060001
    LITTLE, Christopher William
    7 Hoewood
    Mill Glade Small Dole
    BN5 9YR Henfield
    West Sussex
    Amministratore
    7 Hoewood
    Mill Glade Small Dole
    BN5 9YR Henfield
    West Sussex
    British52244990001
    MORGAN, Robert
    Cribbs Cottage
    The Drift Road, Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Cribbs Cottage
    The Drift Road, Wymondham
    LE14 2BP Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish67125120004
    MORRISON, Robert Henry
    70 Wandsworth Road
    BT4 3LW Belfast
    Northern Ireland
    Amministratore
    70 Wandsworth Road
    BT4 3LW Belfast
    Northern Ireland
    British144532690001
    ODONNELL, John
    Residence 23
    Four Seasons Hotel
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Residence 23
    Four Seasons Hotel
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish116667440002
    OVERTON, Antony John
    21 Manor Avenue
    CW2 8BD Wistaston
    Cheshire
    Amministratore
    21 Manor Avenue
    CW2 8BD Wistaston
    Cheshire
    British82484430001
    PATRICK, Ian Jeremy
    The Dovecote
    Tom Lane Chapel Street,
    LS25 5HP Hillam
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Dovecote
    Tom Lane Chapel Street,
    LS25 5HP Hillam
    North Yorkshire
    United KingdomBritish76118010002
    STRINGER, Paul Stephen
    18 Glebe Field Drive
    LS22 6WG Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    18 Glebe Field Drive
    LS22 6WG Wetherby
    West Yorkshire
    British2617020001
    TONKS, Paul Jonathan
    118 Wrottesley Road West
    WV6 8UR Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    118 Wrottesley Road West
    WV6 8UR Wolverhampton
    West Midlands
    British66963520001

    A.R.DAUNT & CO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 mag 2003
    Consegnato il 29 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 29 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land on the east side of bay manor lane west thurrock t/n EX379712 and arden house churchill park colwich nottingham t/n NT272859. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 29 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 12 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 160 and 160A bramcote lane wollaton title number NT115773. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 12 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 20 high street bottesford title number LT196875. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 12 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 557 aspley lane aspley nottingham title number NT60687. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 feb 1977
    Consegnato il 21 feb 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See attached schedule).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 21 feb 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0