CUNDY DECORATIONS LIMITED

CUNDY DECORATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCUNDY DECORATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00625808
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Clc Group Ltd Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARKER-CUNDY DECORATIONS LIMITED14 apr 195914 apr 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ago 2013

    Stato del capitale al 19 ago 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Malcolm John White il 01 giu 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Malcolm John White il 01 giu 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Benjamin Thomas Armitage il 01 giu 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CUNDY DECORATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITE, Malcolm John
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    Segretario
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    BritishAccountant110398690002
    ARMITAGE, Peter Benjamin Thomas
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    Amministratore
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director72943340002
    WHITE, Malcolm John
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    Amministratore
    Unit 2 Vincent Avenue
    Shirley
    SO16 6PQ Southampton
    C/O Clc Group Ltd
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant110398690002
    EAVES, Terence Joseph
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    Segretario
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    BritishAccountant125796830001
    GLEAVE, Linda Margaret
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    British54111520001
    ILES, Mark Willmott
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    Segretario
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    BritishFinancial Director23509110002
    JOHNSON, Ian Edward
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    British14396620001
    MATHERS, Stephen
    8 Kingfisher Close
    LE8 9DG Great Glen
    Leicester
    Segretario
    8 Kingfisher Close
    LE8 9DG Great Glen
    Leicester
    British73169370001
    THOMAS, Geoffrey
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    19 Main Street
    Houghton On The Hill
    LE7 9GE Leicester
    Leicestershire
    British13949310001
    CUNDY, Alan Ernest
    18 Woodards View
    BN43 5LH Shoreham By Sea
    West Sussex
    Amministratore
    18 Woodards View
    BN43 5LH Shoreham By Sea
    West Sussex
    BritishDirector14048380001
    DRURY, Peter John
    31 Longmoor Lane
    Sandiacre
    NG10 5LJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    31 Longmoor Lane
    Sandiacre
    NG10 5LJ Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector16238220001
    EAVES, Terence Joseph
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    Amministratore
    86 Spencer Road
    PO33 3AH Ryde
    Isle Of Wight
    EnglandBritishAccountant125796830001
    GLEAVE, Donald Rowland
    34 Guilford Road
    LE2 2RB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Guilford Road
    LE2 2RB Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector13949320001
    GLEAVE, Linda Margaret
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    34 Guilford Road
    Stoneygate
    LE2 2RD Leicester
    Leicestershire
    BritishNon Executive Dir54111520001
    ILES, Mark Willmott
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    209 Cutbush Lane
    Townhill Park
    SO18 2GF Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishFinancial Director23509110002
    JOHNSON, David Alan
    45 Granville Avenue
    LE2 5FL Oadby
    Leicestershire
    Amministratore
    45 Granville Avenue
    LE2 5FL Oadby
    Leicestershire
    EnglandBritishContracts Dir55012210002
    JOHNSON, Ian Edward
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    71 Leicester Road
    Oadby
    LE2 4DF Leicester
    Leicestershire
    BritishFinance Dir14396620001
    SAVAGE, Hilda Margaret
    Powers Court
    Southmeads Road
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Powers Court
    Southmeads Road
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector39947410001
    SAVAGE, James Edward
    Powers Court Southmeads Road
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    Powers Court Southmeads Road
    LE2 2LR Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector8358250001

    CUNDY DECORATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 dic 2004
    Consegnato il 21 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 giu 1995
    Consegnato il 13 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 dic 1994
    Consegnato il 03 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • James Edward Savage
    Transazioni
    • 03 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0