GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED

GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGENUS ANIMAL HEALTH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00626034
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (46460) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Matrix House
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GENUS DISTRIBUTION LIMITED22 mar 200022 mar 2000
    VDC LIMITED22 set 199422 set 1994
    VETERINARY DRUG CO PLC16 apr 195916 apr 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Karim Bitar come amministratore in data 28 giu 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 0.25
    4 pagineSH19

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2015

    Stato del capitale al 20 ott 2015

    • Capitale: GBP 2,756,816
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Denis Noonan il 10 ago 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen David Wilson il 29 giu 2015

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Belvedere House, Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4HG a Matrix House Basing View Basingstoke Hampshire RG21 4DZ in data 29 giu 2015

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2014

    Stato del capitale al 06 ott 2014

    • Capitale: GBP 2,756,816
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 nov 2013

    Stato del capitale al 14 nov 2013

    • Capitale: GBP 2,756,816
    SH01

    Nomina di Cara Crichton come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ian Farrelly come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Stephen David Wilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Worby come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRICHTON, Cara
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Segretario
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    177793060001
    NOONAN, Denis
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    EnglandIrishGroup Head Of Tax & Treasury126374180003
    WILSON, Stephen David
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    EnglandBritishGroup Finance Director80682720001
    FAIRALL, David Lawrence
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    Segretario
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    BritishCompany Secretary66614300001
    FARRELLY, Ian Brian
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Segretario
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    British71425280002
    HALL, Francis
    58 Pillory Street
    CW5 5BG Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    58 Pillory Street
    CW5 5BG Nantwich
    Cheshire
    British75404160001
    RABONE, Robert
    Walkington Park
    Little Weighton Road, Walkington
    HU17 8SP Beverley
    East Yorkshire
    Segretario
    Walkington Park
    Little Weighton Road, Walkington
    HU17 8SP Beverley
    East Yorkshire
    BritishDirector113482740001
    RICHARDSON, Grahame
    Church Farm House Main Street
    Stillington
    YO6 1JS York
    North Yorkshire
    Segretario
    Church Farm House Main Street
    Stillington
    YO6 1JS York
    North Yorkshire
    British16847670002
    TIMMINS, David Peter
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    Segretario
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director96939310003
    VICKERS, Christopher John
    Cross Lanes
    Clandon Road
    GU4 7UW West Clandon
    Surrey
    Segretario
    Cross Lanes
    Clandon Road
    GU4 7UW West Clandon
    Surrey
    British86434440001
    ACTON, Thomas Philip
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Amministratore
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    EnglandBritishFinance Director177989090001
    BITAR, Karim
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4DZ Basingstoke
    Matrix House
    Hampshire
    England
    United KingdomAmericanCeo162877990001
    BODEN, Martin Brett
    South House
    The Green Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    Oxford
    Amministratore
    South House
    The Green Adderbury
    OX17 3NE Banbury
    Oxford
    BritishFinance Director79799440002
    BOOTH, Simon James
    11b Church Lane
    Garforth
    LS25 1NW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11b Church Lane
    Garforth
    LS25 1NW Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant110713620001
    BOWEN, Richard James
    4 Lakeside View
    CW5 7GA Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    4 Lakeside View
    CW5 7GA Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director75702570001
    BOWEN, Richard James
    4 Lakeside View
    CW5 7GA Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    4 Lakeside View
    CW5 7GA Nantwich
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director75702570001
    BOWER, John Stephen Morton
    East Worthele
    Ermington
    PL21 9JU Ivybridge
    Devon
    Amministratore
    East Worthele
    Ermington
    PL21 9JU Ivybridge
    Devon
    United KingdomBritishVeterinary Surgeon24983580001
    CROOKS, John Leslie
    Westwood Mill
    HU17 8RG Beverley
    Humberside
    Amministratore
    Westwood Mill
    HU17 8RG Beverley
    Humberside
    BritishVeterinary Surgeon (Retired)16847720001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Amministratore
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    DICKINSON, Graham Russell
    Aughton Hall
    Aughton
    YO42 4PG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Aughton Hall
    Aughton
    YO42 4PG York
    North Yorkshire
    BritishExport Director66523300001
    FAIRALL, Lawrence David
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    2 Four Seasons Close
    CW2 6TN Crewe
    Cheshire
    BritishCompany Secretary41072230001
    FISHER, Ernest James
    Ryde House
    The Ryde
    YO3 6XY Skelton
    Yorkshire
    Amministratore
    Ryde House
    The Ryde
    YO3 6XY Skelton
    Yorkshire
    BritishDirector34543990001
    HENDERSON, Gordon Nicholson
    Ryde House
    GU23 6AT Ripley
    Surrey
    Amministratore
    Ryde House
    GU23 6AT Ripley
    Surrey
    BritishVeterinary Surgeon (Retired)/Publisher9538810001
    JACKSON, Paul Rodney
    Lilac Cottage
    Cross Lane Stocksmoor
    HD4 6XH Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Lilac Cottage
    Cross Lane Stocksmoor
    HD4 6XH Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant35024880001
    RABONE, Robert
    Walkington Park
    Little Weighton Road, Walkington
    HU17 8SP Beverley
    East Yorkshire
    Amministratore
    Walkington Park
    Little Weighton Road, Walkington
    HU17 8SP Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritishDirector113482740001
    RICHARDSON, Grahame
    Church Farm House Main Street
    Stillington
    YO6 1JS York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Church Farm House Main Street
    Stillington
    YO6 1JS York
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant16847670002
    ROLLER, Michael Roy David
    Hope Cottage
    Livery Road
    SP5 1RF Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Hope Cottage
    Livery Road
    SP5 1RF Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director59319870004
    SANDERSON, Peter John
    Hawthorn House Back Lane
    Barmby Moor
    YO4 5EW York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Hawthorn House Back Lane
    Barmby Moor
    YO4 5EW York
    North Yorkshire
    BritishSales Director16847700001
    SHATTOCK, Gordon, Sir
    Lea House
    Bishopsteignton
    TQ14 9TP Teignmouth
    Devon
    Amministratore
    Lea House
    Bishopsteignton
    TQ14 9TP Teignmouth
    Devon
    BritishVeterinary Surgeon (Retired)29230120001
    TANDY, John
    Tudor House Kingsley Road
    Dentons Green
    WA10 6JN St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    Tudor House Kingsley Road
    Dentons Green
    WA10 6JN St Helens
    Merseyside
    BritishVeterinary Surgeon127631910001
    TIMMINS, David Peter
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    Stable Cottage
    Mulsford Lane, Worthenbury
    LL13 0AW Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director96939310003
    WHETSTONE, Stephen
    The Grange 7 Lakeside Gardens
    Strensall
    YO32 5WB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Grange 7 Lakeside Gardens
    Strensall
    YO32 5WB York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director66009420001
    WOOD, Richard Kenneth
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    Amministratore
    Belvedere House, Basing View
    Basingstoke
    RG21 4HG Hampshire
    EnglandBritishChief Executive102208990001
    WORBY, John Graham
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    Belvedere House
    Hampshire
    Amministratore
    Basing View
    RG21 4HG Basingstoke
    Belvedere House
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant137236910001

    GENUS ANIMAL HEALTH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 04 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 04 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of accession (to a composite guarantee and mortgage debenture dated 15 november 1999)
    Creato il 09 dic 1999
    Consegnato il 11 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) and/or the foreign companies (as defined) or any of them to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (the "security trustee") under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 gen 1981
    Consegnato il 11 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land on the north east of hambridge lane, greenham, newbury, berks. Title no. Bk 192971.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0