CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00629193
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KENNEDY'S SCAFFOLDING LIMITED09 apr 199109 apr 1991
    WESTERN SCAFFOLDING COMPANY LIMITED29 mag 195929 mag 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Drayton Hall Church Road West Drayton Middlesex England UB7 7PS a 15 Canada Square London E14 5GL in data 13 gen 2017

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 dic 2016

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Friend Allan come segretario in data 07 giu 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Friend Allan come amministratore in data 07 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2016

    Stato del capitale al 12 mag 2016

    • Capitale: GBP 4,984.8
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2015

    Stato del capitale al 25 mar 2015

    • Capitale: GBP 4,984.8
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mar 2014

    Stato del capitale al 20 mar 2014

    • Capitale: GBP 4,984.8
    SH01

    Nomina di Mr Mark Hooper come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Friend Allan come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Skipp come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Judd come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Richard Friend Allan come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Anne George il 08 mag 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Richard John Skipp come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rachel Amey come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom* in data 14 mar 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GEORGE, Victoria Anne
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish134024500001
    HOOPER, Mark
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Amministratore
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    United KingdomBritish183414240001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    181728890001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    British82905830001
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675550001
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    Segretario
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    169521430001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    REYNOLDS, Michael Thomas
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    British4978610002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Segretario
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Segretario
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    British99402260002
    AINLEY, Paul Raymond
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    Manasseh
    Darrington Road
    WF8 3RY Pontefract
    West Yorkshire
    British36049300001
    ALLAN, Richard Friend
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Drayton Hall
    Church Road
    UB7 7PS West Drayton
    Cape Intermediate Holdings Plc
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish183409640001
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritish133976650005
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Amministratore
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    British131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Amministratore
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    British40873830002
    CRAIG, William Thomas
    Dunelm Moat Lane
    Prestwood
    HP16 9BT Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Dunelm Moat Lane
    Prestwood
    HP16 9BT Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33602340001
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    British82905830001
    GAMMAGE, Julian
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    99 High Road
    Warmsworth
    DN4 9LZ Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish13299700001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89560440001
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish15469790001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish829660002
    REYNOLDS, Michael Thomas
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    185 Adel Lane
    LS16 8BY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4978610002
    SKIPP, Richard John
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    Amministratore
    Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    Drayton Hall
    England
    England
    EnglandBritish164010970001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    British64449570001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Amministratore
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritish99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Brevi particolari
    Freehold properties,(i) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 28 apr 1987
    Consegnato il 07 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing sterling 3,458,848 10% debenture stock 1986/91 of cape industries public limited company and all other moneys due or to become due pursuant to this deed.
    Brevi particolari
    And all patents. See doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 29 gen 1985
    Consegnato il 14 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) the f/h l/h property of the company 2) all stocks shares bonds and securities 3) all book & other debts 4) uncalled capital goodwill and all patents. Paten applications trade marks etc. 5) undertaking and all other property assets and rights (for full details see doc M46).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1985
    Consegnato il 04 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminister bank PLC as trustee for itself and other banks named therein on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    A specific eqitable charge over the companys f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets presnt and future including and the goodwill bookdebts benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminister Bank Plcand Other Banks (See Doc for Details).
    Transazioni
    • 04 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 11 nov 1982
    Consegnato il 18 nov 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital, with all buildings trade & other fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1982Registrazione di un'ipoteca

    CAPE INDUSTRIAL SERVICES HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 dic 2017Data di scioglimento
    20 dic 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0