CAPARO INDUSTRIES PLC

CAPARO INDUSTRIES PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPARO INDUSTRIES PLC
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00630473
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CAPARO INDUSTRIES PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Floor 8 Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    L.K.INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED16 giu 195916 giu 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    14 pagineAM16

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    26 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    14 pagineAM16

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    8 pagineRM02

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    18 pagineAM16

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:C.O. To file progress reports annually not 6 monthly.
    3 pagineLIQ MISC OC

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da 7 More London Riverside London SE1 2RT a Floor 8 Central Square 29 Wellington Street Leeds Yorkshire LS1 4DL in data 09 ott 2017

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    2 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Chi sono gli amministratori di CAPARO INDUSTRIES PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAILEY, Stephen Geoffrey
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    Segretario
    Abbey Gardens
    ST18 0RY Great Haywood
    1
    Staffordshire
    British108203800001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Segretario
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HYLAND, Matthew Edward William
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Segretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    194838470001
    JEAVONS, William Geoffrey
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    1 The Grange
    Wombourne
    WV5 9HX Wolverhampton
    West Midlands
    British11293410001
    MASON, Georgina
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Segretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    173195350001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    British56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British10618480001
    STILWELL, Michael James
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Segretario
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    150882120001
    BUTLER, Richard Gareth John
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    Amministratore
    The Field House
    Rashwood
    WR9 0BS Droitwich Spa
    Worcestershire
    EnglandBritish117859680001
    DANCASTER, David Patrick
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    Amministratore
    Kenilworth Avenue
    SW19 7LN London
    1
    EnglandBritish55380530001
    DAWSON, Douglas, Dr
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Amministratore
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish117734230001
    EMMENEGGER, Charles E
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    Amministratore
    1819 Clarkson Road
    FOREIGN Chesterfield
    Missouri 63017
    Usa
    United States Of America37965200001
    GANE, Christopher Nigel
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Amministratore
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    ScotlandBritish73268030001
    GARDNER, Norman Arthur
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    Amministratore
    210a Stroud Road
    GL1 5LA Gloucester
    Gloucestershire
    British61016230001
    HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Tile House 26 Pound Lane
    Sonning On Thames
    RG4 6XE Reading
    Berkshire
    British12310490001
    HAUXWELL, Timothy Norbury
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    Amministratore
    The Shielings Highgrove Gardens
    Edwalton
    NG12 4DF Nottingham
    British70993740001
    JARVIS, Andrew Laurence
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    Amministratore
    Beaumont
    Beaufort Road, Osbaston
    NP25 3HU Monmouth
    Monmouthshire
    United KingdomBritish93158620001
    LEEK, James Anthony
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    Amministratore
    8 Atherton Drive
    Wimbledon
    SW19 5LB London
    British11293430001
    LORMOR, Paul Frederick
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    Amministratore
    23 Kirton Road
    Scotter
    DN21 3SW Gainsborough
    Lincolnshire
    British30814040001
    MEYER, John Joseph
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    Amministratore
    14929 Greenbury Hill Court
    Chesterfield
    Missouri 63017
    Missouri
    UsaAmerican147066260001
    MORRILL, Dennis
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    Amministratore
    Raven Drive
    St Peters Park
    WR5 3LR Worcester
    17
    Worcestershire
    United KingdomBritish111395730002
    O'REILLY, Derek Michael
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    EnglandBritish108440160002
    PAHILAJANI, Sunil
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Amministratore
    A-1, 54, Ground Floor
    Safdarjang Enclave
    New Dehli
    110016
    India
    Indian119093750001
    PAUL, Akash, The Honourable
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambkia House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 3
    United Kingdom
    United KingdomBritish49303360005
    PAUL, Akhil
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    Amministratore
    More London Riverside
    SE1 2RT London
    7
    United KingdomBritish147065830001
    PAUL, Ambar, The Honourable
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambika House 9-11
    Portland Place
    W1B 1PR London
    Flat 19
    United Kingdom
    United KingdomBritish92729600003
    PAUL, Angad, The Honorable
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    Amministratore
    Ambika House 9a
    Portland Place
    W1B 1PR London
    The Penthouse Flat
    United KingdomUnited Kingdom130813310001
    PAUL, Anjli, The Hon
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Amministratore
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    United KingdomBritish110279150001
    PAUL OF MARYLEBONE, The Lord
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    Amministratore
    6 Ambika House
    9a Portland Place
    W1B 1PR London
    EnglandBritish11293420003
    PAY, Jason Christopher
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    Amministratore
    103 Baker Street
    W1U 6LN London
    Caparo House
    EnglandBritish126516810001
    SCHEELE, Nicholas, Sir
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    Amministratore
    Caparo House
    Popes Lane
    B69 4PJ Oldbury
    West Midlands
    British American116839800001
    SHAW, Christopher Norman
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    Amministratore
    Castle Vale
    Castle Street, Raglan
    NP15 2DS Usk
    Gwent
    United KingdomBritish28831060001
    SMITH, John Godfrey
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Chequerfield House
    32 Showell Lane Lower Penn
    WV4 4TT Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish56051330001
    STEELE, Colin Grant
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hindrum Cokes Lane
    HP8 4UD Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10618480001

    CAPARO INDUSTRIES PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 15 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H real estate:. Cmt engineering, congreaves road, cradley heath t/no WM904133.. Units 9 & 13 -5-7 wenlock road, london t/no's EGL525392, EGL525389 and EGL525391.. Land adjoing walsall canal, old birchills, walsall t/no WM928137. (For further details of properties charged please refer to form MR01) see image for full details. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited
    Transazioni
    • 15 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 06 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land adjoining walsall canal old birchills walsall t/no WM928137. F/h land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood t/no WM664003. F/h land and buildings o the north east side of miner street walsall t/no WM383832. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo Pensions Scheme Trustee Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 222 ott 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 222 ott 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 213 nov 2019Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 05 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land k/a cmt engineering corngreaves road cradley heath t/no WM904133. F/h land (ground lease) k/a units 9 - 5-7 wenlock road london t/nos EGL525392, EGL525389, EGL525394 and EGL525391. Trade mark registered in the UK with number 2623030 in relation to the word mark "barton filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. trade mark registered in the republic of ireland with number N247732 in relation to the word mark "barton" filed in 2012 with reference to classes 6 and 9. notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 05 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2013
    Consegnato il 01 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    F/H property being the land adjoining walsall canal old birchills walsall (WM928137) land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood (WM664003) and land and building on the north east side of miner walsall (WM383832). Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Caparo Group Limited
    Transazioni
    • 01 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Share charge
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 13 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in the shares being 10,000 ordinary shares and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caparo Pensions Scheme Trustees Limited in Its Capacity as Trustee for the Caparo 1988 Pension Scheme
    Transazioni
    • 13 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 09 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property land adjoining walsall canal, old bircills walsall, t/no.WM928137; land lying to the west of rayboulds bridge road reedswood, t/no.WM664003; land and buildings on the north east side of miner street walsall, t/no.WM383832 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 09 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All shares in caparo india limited and all related rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 05 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or geneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caparo Group Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Share charge
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 05 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares means in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caparo PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Share charge
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 05 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Shares mean in relation to the chargor all of the shares in caparo india limited owned legally or beneficially by it or held by the chargee or any nominee on its behalf (including 10,000 ordinary shares) and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caparo Group Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security agreement
    Creato il 30 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 feb 2009
    Consegnato il 18 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a as land lying to the west of raybould's bridge road, reedswood, land adjoining walsall canal, old brichills, walsall and land and buildings to the north east side of miner street, walsall t/no WM66003, WM928137, and WM383832.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2009
    • 20 feb 2009
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 lug 2007
    Consegnato il 07 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H properties k/a units 9 and 13 and parking spaces 21 and 22 "estilo wenlock road london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 28 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a corngreaves road cradley t/no WM489303.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 05 apr 1985
    Consegnato il 12 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All ordinary and deferred shared in caparo management services limited held in the name of fenchurch securities LTD. All ordinary and deferred shares in barton group PLC owned by the charger.
    Persone aventi diritto
    • Kleinwort, Benson Limited.
    Transazioni
    • 12 apr 1985Registrazione di un'ipoteca

    CAPARO INDUSTRIES PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 ott 2015Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Anthony Steven Barrell
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Edward Williams
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Suzanna Vida Marshall
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Andrew Lamb
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    75-76 Francis Road
    Edgbaston
    B16 8SP Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0