LEAFIELD ENGINEERING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LEAFIELD ENGINEERING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00634776 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE AND DEFENCE LIMITED | 04 giu 1987 | 04 giu 1987 |
| HONEYWELL LEAFIELD LIMITED | 08 nov 1983 | 08 nov 1983 |
| LEAFIELDS ENGINEERING LIMITED | 11 ago 1959 | 11 ago 1959 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 09 apr 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Sarah Louise Ellard come amministratore in data 31 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Flowers il 13 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Michael James Flowers come amministratore in data 24 lug 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Segretario | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| CHAPPLE, Timothy Jonathan | Segretario | 18 Roger Beck Way Sketty SA2 0JF Swansea | British | 28933940002 | ||||||
| EDWARDS, David Stephen | Segretario | 92 St Austell Way Penzance Drive SN2 2DG Swindon Wiltshire | British | 64259030002 | ||||||
| FORSYTH, Nigel John | Segretario | Park Farm Barn PO7 4SB Hambledon Hampshire | British | 59380470002 | ||||||
| WHADCOCK, Stephen Arthur | Segretario | 75 Nursteed Road SN10 3AJ Devizes Wiltshire | British | 6425330001 | ||||||
| BLOTT, James | Amministratore | The Rest West Street PO7 4RW Hambledon Hampshire | British | 59380580002 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| CARPENTER, Cecil John | Amministratore | Zion Hill Cottage Clapton BA3 4DZ Bath | England | British | 98361540001 | |||||
| CHAPPLE, Timothy Jonathan | Amministratore | 18 Roger Beck Way Sketty SA2 0JF Swansea | British | 28933940002 | ||||||
| DYKE, Robert Alexander | Amministratore | Grove Farm 156 Winsley Road BA15 1PA Bradford On Avon Wiltshire | England | British | 51678350002 | |||||
| EDWARDS, David Stephen | Amministratore | 92 St Austell Way Penzance Drive SN2 2DG Swindon Wiltshire | British | 64259030002 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| FORSYTH, Nigel John | Amministratore | Park Farm Barn PO7 4SB Hambledon Hampshire | British | 59380470002 | ||||||
| HAMILTON, Archibald Gavin, The Right Honourable Sir | Amministratore | Snowdenham House Snowdenham Lane Bramley GU5 0DB Guildford Surrey | British | 36648100001 | ||||||
| HAMILTON OF EPSOM, Archibald Gavin, Lord | Amministratore | 14 Tufton Court Tufton Street Tufton SW1P 3QH London | England | British | 112172480001 | |||||
| HELME, Michael John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | England | British | 91910030002 | |||||
| JACOMB, Kenneth Edward | Amministratore | Holly Tree Farm Sandy Lane SN12 2QB Chippenham Wiltshire | British | 6425340001 | ||||||
| MEREDITH, Brian Horace | Amministratore | 20a The Street Broughton Gifford SN12 8PW Melksham Wiltshire | British | 26601600001 | ||||||
| MUNRO, Peter Austin Dods | Amministratore | The Wing Selwood Lodge Leys Lane BA11 2JX Frome Somerset | British | 67696410002 | ||||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| TONGE, Richard Leslie | Amministratore | 4 Trimnells Colerne SN14 8EP Chippenham Wiltshire | British | 6425360001 | ||||||
| WHADCOCK, Stephen Arthur | Amministratore | 75 Nursteed Road SN10 3AJ Devizes Wiltshire | British | 6425330001 | ||||||
| WOODS, Stephen William | Amministratore | 1 Silver Street Gastard SN13 9PY Corsham Wiltshire | England | British | 64258950002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LEAFIELD ENGINEERING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemring Energetics Uk Limited | 30 giu 2016 | Ardeer Site KA20 3LN Stevenston Troon House Ayrshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LEAFIELD ENGINEERING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 30 giu 2003 Consegnato il 05 lug 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 08 feb 1996 Consegnato il 21 feb 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 mar 1990 Consegnato il 23 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,050,000 from the company to the chargee | |
Brevi particolari All the assets and undertaking of the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A credit agreement entitled "credit application" | Creato il 23 feb 1990 Consegnato il 28 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to close brothers limited under the terms of the credit application | |
Brevi particolari All rights, title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are detailed on the reverse of the form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 21 dic 1989 Consegnato il 03 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration at the register of sasines on the 29/8/83 | Creato il 02 set 1983 Consegnato il 02 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company under the terms of a personal band of even date. | |
Brevi particolari Lease by glenrothes development corporation in favour of leafields engineering limited (see doc M89 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration at the register of sasines on the 29/8/83. | Creato il 01 set 1983 Consegnato il 01 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 9.587 acres or thereby at south field industrial estate kinglassie fife (see doc M88 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0