TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED

TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00639535
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Siu Ping Lau il 10 set 2022

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    9 pagineAA

    Cessazione di Coquet Shipping Company Limited come persona con controllo significativo il 11 ago 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Kenwake Ltd come persona con controllo significativo il 11 ago 2022

    2 paginePSC02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Junguang Xiao il 11 ago 2022

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re-company business 11/08/2022
    RES13

    Stato del capitale al 23 ago 2022

    • Capitale: GBP 1.07498
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Richard Banham come amministratore in data 01 gen 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Junguang Xiao come amministratore in data 01 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Chee Fun Lee come amministratore in data 01 nov 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Tuen Pei Pius Lam come amministratore in data 01 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Siu Ping Lau come amministratore in data 01 mar 2020

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OOCL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Segretario
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    76693230001
    BANHAM, Mark Richard
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Amministratore
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    EnglandBritishAccountant57940780001
    LAU, Siu Ping
    One Harbour Square,181 Hoi Bun Road,Kwun Tong
    Kowloon
    15/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    One Harbour Square,181 Hoi Bun Road,Kwun Tong
    Kowloon
    15/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Hong KongChineseDirector268294940002
    XIAO, Junguang
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    Amministratore
    Harbour Centre
    25 Harbour Road
    Wanchai
    31/F
    Hong Kong
    Hong Kong
    ChinaChineseDirector277280010002
    MORRISON, William Stuart
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    British37064540002
    RUSSELL, Howard Neil
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    Segretario
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    British3000800001
    BANHAM, Mark Richard
    6 Mannington Close
    Rushmere St Andrew
    IP4 5PW Ipswich
    Amministratore
    6 Mannington Close
    Rushmere St Andrew
    IP4 5PW Ipswich
    EnglandBritishAccountant57940780001
    FUNG, Kit Man
    26d Tower 5-Rambler Crest
    1 Tsing Yi Road
    Tsing Yi
    Hong Kong
    Amministratore
    26d Tower 5-Rambler Crest
    1 Tsing Yi Road
    Tsing Yi
    Hong Kong
    ChineseAccountant76693040002
    HSIA, John Welfen
    23 Conduit Road
    FOREIGN Hong Kong
    Amministratore
    23 Conduit Road
    FOREIGN Hong Kong
    AmericanCompany Director32121220001
    LAM, Tuen Pei Pius
    181 Hoi Bun Road Kwun Tong
    Kowloon
    Hong Kong
    15/F One Harbour Square
    Hong Kong
    Amministratore
    181 Hoi Bun Road Kwun Tong
    Kowloon
    Hong Kong
    15/F One Harbour Square
    Hong Kong
    Hong KongAustralianGroup Financial Controller208569380001
    LEE, Chee Fun
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Amministratore
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Hong KongMalaysianGroup Legal Advisor76693610002
    MOK, Paul Yun Lee
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    Amministratore
    Oocl House, Levington Park
    Bridge Road, Levington
    IP10 0NE Ipswich, Suffolk
    BritishGroup Financial Controller131049380001
    MORRISON, William Stuart
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Timbertops
    Purdis Farm Lane
    IP3 8UF Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritishChartered Accountant37064540002
    ROBINSON, Frank William
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    Amministratore
    33 Sebastian Avenue
    Shenfield
    CM15 8PW Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director2664580001
    RUSSELL, Howard Neil
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    Amministratore
    3 Happisburgh House
    Priory Road
    IP11 7NE Felixstowe
    Suffolk
    BritishCompany Secretary3000800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Kenwake Ltd
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    England
    11 ago 2022
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione01473779
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Coquet Shipping Company Limited
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    Suffolk
    England
    06 apr 2016
    Bridge Road
    Levington
    IP10 0NE Ipswich
    Oocl House
    Suffolk
    England
    Forma giuridicaLimited
    Autorità legaleEngland And Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    TYNEDALE SHIPPING COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of covenants
    Creato il 29 dic 1983
    Consegnato il 04 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    All policies and contracts of insurance in respect of manchester challenge and her freights disbursments & projects (please see doc M72).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank International Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Ships mortgage
    Creato il 29 dic 1983
    Consegnato il 04 gen 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under the terms of a loan agreements & a deed of covenant each dated 29.12.83
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the british flag vessel k/a: M.V. manchester challenge reg: at port of bristol with official no: 33746 and her boats & appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank International Limited
    Transazioni
    • 04 gen 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 31 lug 1981
    Consegnato il 04 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing all monies due or to become due from thecompany to the chargee secured by a charge dated 31/7/81 under the terms of a loan agreement dated 31/7/81 and the deed of covenants dated 31/7/81
    Brevi particolari
    64/64TH shares in M.V. daart america official no.337546 Registered at port of bristol all the insurances & earnings requisition compensations as effected in the deed of covenants.
    Persone aventi diritto
    • Midland Marine Bank N A.
    Transazioni
    • 04 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Statutory ship mortgage
    Creato il 31 lug 1981
    Consegnato il 04 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargee on any account current under the terms of a guarantee, the loan agreement and deed of covenants dated 31/7/81
    Brevi particolari
    64/64TH shares in M.V. dart america official no. 337546 port of registration bristol.
    Persone aventi diritto
    • Marine Midland Bank N.A.
    Transazioni
    • 04 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental deed of covenant
    Creato il 19 mag 1981
    Consegnato il 03 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £9,650,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee secured by a statutory mortgage dated 19/5/81 under the terms of a loan agreement and deed of covenant dated 15/no/79 amended by a loan agreement of even date.
    Brevi particolari
    The vessel "dart america" reg at port of bristol no 11 in 1970 official no 337546. earnings and requisition compensation.
    Persone aventi diritto
    • Marine Midland Bank N.A.
    Transazioni
    • 03 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Statutory mortgage
    Creato il 19 mag 1981
    Consegnato il 03 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargee on any accounts current under the terms of a loan agreement and deed of covenant both dated 15/10/79 amended by a loan agreement and deedof covenant of even date
    Brevi particolari
    64/64TH shares in M.V. "dart america" reg in port of bristol no: 11 in 1970 official no 337546.
    Persone aventi diritto
    • Marine Midland Bank LTD
    Transazioni
    • 03 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 15 ott 1979
    Consegnato il 30 ott 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due from the company to the chargee secured by agreement dated 9/11/79 supplemental to a statutory mortgage 19/8/79
    Brevi particolari
    M.V. "dart america" british ship registered tynedale at port of bristol no.337546.the vessel all interests, rights,title and in tynedaleand to the insurances effected on the vessel and charterhire.
    Persone aventi diritto
    • Marine Midland Bank
    Transazioni
    • 30 ott 1979Registrazione di un'ipoteca
    Statutory ship mortgage
    Creato il 15 ott 1979
    Consegnato il 23 ott 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an ac count current under the terms of a loan agreement and a deed of covenant both dated 15/10/79.
    Brevi particolari
    M.V. "dart america" registered at bristol with official no. 337546. (for full details see doc M65).
    Persone aventi diritto
    • Marine Midland Bank
    Transazioni
    • 23 ott 1979Registrazione di un'ipoteca
    Deed of covenant
    Creato il 11 nov 1974
    Consegnato il 02 dic 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Dated 11.12.74 further securing all monies due or to bec ome due secured by two other charges. Both dated 11.11.74 registered pursuant tosection 95 of companies act 1948 on 2.12.74.
    Brevi particolari
    A) all policies contracts of insuranace.
    Persone aventi diritto
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transazioni
    • 02 dic 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory ship mortgage
    Creato il 11 nov 1974
    Consegnato il 02 dic 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due form the company to the chargee on an ac count current under terms of an agreement & deed of covenants both dated 11.11.74
    Brevi particolari
    The vessel "dart america".
    Persone aventi diritto
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transazioni
    • 02 dic 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Statutory ship mortgage
    Creato il 11 nov 1974
    Consegnato il 02 dic 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account current under terms of an agreement & deed of covenants both dated 11/11/1974.
    Brevi particolari
    The vessel " atlantic phoenix".
    Persone aventi diritto
    • Coquet Shipping Company LTD
    Transazioni
    • 02 dic 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stat. Mortgage
    Creato il 08 nov 1974
    Consegnato il 18 nov 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    35,681,887.98 french francs and all other monies due or to become due from the co. To the changee under the terms of a credit agreement dtd. 10.9.70 as amended & transferred and of a deed of covenant dtd 8.11.70
    Brevi particolari
    Sixty four sixty-fourth shares in mv atlantic phoenix.
    Persone aventi diritto
    • Banque Francaese Du Commerce Exterieur
    Transazioni
    • 18 nov 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenants.
    Creato il 08 nov 1974
    Consegnato il 18 nov 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    35,681,887.98 french francs and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a credit agreemnt dtd 10.9.70 asamended & transferred and secured by a charg dtd 8.11.74
    Brevi particolari
    The ship and all policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Banque Francaese Du Commerce Exterieur
    Transazioni
    • 18 nov 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 11 nov 1971
    Consegnato il 12 nov 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £5,680,000 all other monies due etc. pursu ant to an agreement dated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Monies payable to the company under a container chester dated 29TH june 1970.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of agreement
    Creato il 11 nov 1971
    Consegnato il 12 nov 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing 5,680,000 and all other monies due or to become du e from the company to the chargee pursuant to the terms of a financial agreementdated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    All the company rights title & interest in any monies payable to them under an agreement dated 11-11-71 under a further agreement of even date.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 11 nov 1971
    Consegnato il 12 nov 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £5,680,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a financial agre ement dated 23RD may 1969 and deeds supplemental thereto.
    Brevi particolari
    All the company rights title & interest in any monies payable to them under an agreement dated 11-11-71.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 11 nov 1971
    Consegnato il 11 nov 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Deed of assignment securing £5,680,000 and all other monies due etc. pursuantto an any agreement dated 23RD may 1969 and dated supplemental thereto.
    Brevi particolari
    Monies payable to the company under a container chester dated 29TH june 1970 and any further containers. See co 32 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 1971Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 nov 1970
    Consegnato il 04 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,680,000 and all other moneys due pursuant to the terms of the financial agreement dated 23.5.69 and deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    For details of two sums of money deposited with the bank see doc (30).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 30 nov 1970
    Consegnato il 04 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £5,680,000 and all other monies due et C. pursuant to the terms of the financial agreement dated 23RD may 1969 and deeds suppllemental thereto
    Brevi particolari
    The containers, supplied or to be supplied by swan hunter ship builders LTD. For "dart america".
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 30 nov 1970
    Consegnato il 04 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £5,680,000 and all other monies due or to become due under the financial agreement, the mortgage the deed of covenant & the deed of assignment
    Brevi particolari
    All the companys right title & interest in any monies payable by dart containerline company LTD under a time charterparty dated 2.5.69 and addendum dated 4.11.70 and all other rights & benefits due to the company (for full details see doc 29).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 30 nov 1970
    Consegnato il 04 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £5,680,000 and all other monies due etc. pursuant to the terms of a financial agreement dated 23RD may 1969, & change dated 30-11-70 & further securing all monies due or to become due to morgan grenfell & co LTD under the terms of a facility letter 14TH january 69 and another deed dated 23RD may 1969
    Brevi particolari
    The mortgaged premises being the ship, the containers, insurances, earnings of the ship & requisition, compensation as defined in the deed of covenant.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Ships mortgage
    Creato il 30 nov 1970
    Consegnato il 04 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all monies due or to become due on an account curr ent pursuant to a financial agreement dated 23-5-69 and a deed of covenant dated 30 november 1970 and another deed dated 23RD may 69
    Brevi particolari
    The motor vessel "deut america" official no 337546.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 23 mag 1969
    Consegnato il 29 mag 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,040,000 tog: with a commitment of 1% and all other monies due from theco.LTD to the bank pursuant to the terms of the agreement as well as all monies due to morgan grenfell & co. Under the terms of a facility letter dated 14/1/69 and another deed dated 23/3/63
    Brevi particolari
    (1) all the owners beneficial interest and all its benefits rights and titles in a building contract dated 30 july 1968 for the ship being built and known during construction as yard no 14 (the vessel) as she is constructed (2) all monies payable to the owner in respect of the insurance effected by the builder (see doc 26 for further details).
    Persone aventi diritto
    • National Provincial Bank LTD
    Transazioni
    • 29 mag 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0