LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED

LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00640499
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Onslow House
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Essex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Lb Group come segretario in data 26 apr 2016

    1 pagineTM02

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Lb Group come segretario

    2 pagineAP04

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2009

    5 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2011

    Stato del capitale al 15 apr 2011

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Indirizzo della sede legale modificato da * 129 New London Road Chelmsford Essex CM2 0QT* in data 23 feb 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORGAN, Derek Reginald
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    British126193150001
    MORGAN, Ryan Francis Kenneth
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandEnglish116420720002
    PLATT, Ryan Henry John
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    62 Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish128481590001
    BURNEY, Paula
    Ivy Manor
    44-46 Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    Essex
    Segretario
    Ivy Manor
    44-46 Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    Essex
    British124430740001
    GREY, Christopher John
    39 Warren Avenue
    TW10 5DZ Richmond
    Surrey
    Segretario
    39 Warren Avenue
    TW10 5DZ Richmond
    Surrey
    British84361370001
    CR SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario
    120 East Road
    N1 6AA London
    757780001
    LB GROUP
    62
    Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    United Kingdom
    Segretario
    62
    Broomfield Road
    CM1 1SW Chelmsford
    Onslow House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00640499
    166331740001
    MH SECRETARIES LIMITED
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    Segretario
    Staple Court 11 Staple Inn Buildings
    WC1V 7QH London
    123667200001
    WH SECRETARIES LIMITED
    Atlas House Fourth Floor
    1 King Street
    EC2V 8AU London
    Segretario
    Atlas House Fourth Floor
    1 King Street
    EC2V 8AU London
    58494040002
    BURNEY, Daren Mark
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    Amministratore
    Forest Lane
    IG7 5AE Chigwell
    46
    Essex
    United KingdomBritish102580230005
    SPYROPOULOS, Julie Catherine
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    Amministratore
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    British53062950004
    SPYROPOULOS, Theodore Lycourgos
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    Amministratore
    1/2 The Maltings
    High Street, Fordwich
    CT2 0DW Canterbury
    Kent
    British31944200006

    LEDRA INVESTMENT PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    252 and 252A and building plot at the rear of 252 upper richmond road west. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    244 and 244A upper richmond road t/no SY42198. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    49 st peters street canterbury t/no K30204. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    240 and 240A upper richmond road and 135D sheen lane london t/no SY229650.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    159 white hart lane t/no SGL508097. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deposit agreement
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    £35,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 gen 2001
    Consegnato il 06 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A floating charge over the undertaking and all rights properties and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 06 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 23 gen 2001
    Consegnato il 06 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property k/a 49 st pters street canterbury t/n K730204 and 244 upper richmond road east sheen in the london borough of richmond upon thames t/n SY42198 together with all buildings fixtures (including trade fixtures) and fixed plan and machinery from time to time on the mortgaged property and the goodwill of any business carried on on the mortgaged property together with the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 06 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 2000
    Consegnato il 23 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 236 upper richmond road west east sheen l/b richmond-on-thames.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 02 nov 2000
    Consegnato il 10 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the undertaking property and assets of the company whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1999
    Consegnato il 22 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    159 white hart lane barnes london borugh of richmond upon thames t/n SGL508097.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 feb 1998
    Consegnato il 03 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A floating charge over the undertaking and all rights properties and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 feb 1998
    Consegnato il 03 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    252 upper richmond road mortlake t/no;-SY48493. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mag 1996
    Consegnato il 05 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 244 upper richmond road west, east sheen, london t/no. SY42198 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 mag 1996
    Consegnato il 05 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 252 upper richmond road west east sheen london y/n SY48493 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1988
    Consegnato il 07 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    159 white hart lane l/b of richmond upon thames title no:- sgl 508097.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 feb 1985
    Consegnato il 25 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    236/236A/238/240/242 upper richmond road, west london borough of richmond-upon-thames t/n sy 229650.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 dic 1981
    Consegnato il 11 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1 & 1A, sheen road, richmond upon thames, london.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1978
    Consegnato il 05 mag 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    244 upper richmond road, east sheen, london S.W.4.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 28 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 1978
    Consegnato il 20 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    56 paddington street westminster london W.1. title no 393203.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 1978
    Consegnato il 20 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    502, 504 & 506 edgware road, westminster london W.2 title no. 298260 & ln 189914.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 gen 1978
    Consegnato il 20 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45, charlton street N.W.9 camden london title no 362011.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 1975
    Consegnato il 16 gen 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and house, 111 church rd, richmond, surrey.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transazioni
    • 16 gen 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 nov 1970
    Consegnato il 25 nov 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (F/h) 45 charlton street london nw.1 (F/h) 56 paddington street london W.1 (l/h) 502, 504, 506 edgware road london . W.2 fixed and movable plant machinery and fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank LTD
    Transazioni
    • 25 nov 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0