ZENITH PLUMBPOINT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ZENITH PLUMBPOINT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00640740 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HEATEK LABONE LIMITED | 15 nov 1991 | 15 nov 1991 |
| HEATEK SERVICES LIMITED | 29 ott 1959 | 29 ott 1959 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 21 apr 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlstone Road Northampton NN5 7UG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 25 set 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 01 lug 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Deborah Grimason come amministratore in data 06 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 18 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Deborah Grimason come amministratore in data 18 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 11 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan Richard Williams come amministratore in data 11 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| BAKER, John Edgar | Segretario | Old Barn House Yorkley GL15 4RX Lydney Gloucestershire | British | 62612550001 | ||||||||||
| BALL, Ute Suse | Segretario | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | British | 118371550001 | ||||||||||
| EASTWOOD, Jeremy Colin | Segretario | 10 Broad Close Barford St Michael OX15 0RW Banbury Oxfordshire | British | 40739950001 | ||||||||||
| HAMMOND, Geoffrey Byard | Segretario | 273 London Road LE2 3BE Stoneygate Leicestershire | British | 122820710001 | ||||||||||
| HIGGINSON, Kevin Mark | Segretario | The Beeches, Myrtle Lodge Farm Main Street LE65 2TY Smisby Leicestershire | British | 116296480001 | ||||||||||
| JOHNS, David | Segretario | 10 Pantain Road LE11 3NA Loughborough Leicestershire | British | 639840001 | ||||||||||
| MURRAY, John Roderick | Segretario | Flat 1 26 Sumburgh Road SW12 8AJ London | British | 145111310001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | 158160310001 | |||||||||||
| BAKER, John Edgar | Amministratore | Old Barn House Yorkley GL15 4RX Lydney Gloucestershire | United Kingdom | British | 62612550001 | |||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| COOPER, Peter | Amministratore | 1 Brook Terrace Medbourne LE16 8DN Market Harborough Leicestershire | British | 14466860001 | ||||||||||
| DONOVAN, Patrick Wallace | Amministratore | Long Acre College Street LE17 5BU Ullusthorpe Leicestershire | England | British | 89392800001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HIGGINSON, Kevin Mark | Amministratore | The Beeches, Myrtle Lodge Farm Main Street LE65 2TY Smisby Leicestershire | United Kingdom | British | 116296480001 | |||||||||
| HOWROYD, Michael Stanley | Amministratore | Woodvine House Tewkesbury Road Twigworth GL2 9PX Gloucester Gloucestershire | British | 67367050001 | ||||||||||
| LEE, Robert Scott | Amministratore | 32 Grove Road Coombe Dingle BS9 2RL Bristol Avon | British | 14861680001 | ||||||||||
| MILNE, Alan Douglas | Amministratore | 79 Carisbrooke Road LE2 3PF Leicester Leicestershire | British | 65893230001 | ||||||||||
| MURRAY, John Roderick | Amministratore | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | United Kingdom | British | 145111310001 | |||||||||
| SLARK, Gavin | Amministratore | Fleet House Lee Circle LE1 3QQ Leicester | United Kingdom | British | 162972090001 | |||||||||
| WOOD, Peter Scott | Amministratore | 31 Newall Hall Park LS21 2RD Otley West Yorkshire | British | 1732940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ZENITH PLUMBPOINT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bss Group Limited | 06 apr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ZENITH PLUMBPOINT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Creato il 27 nov 1987 Consegnato il 30 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels plant machinery & items one ford cargo phi 1313 & registration number E648 kfb chassis number cxxccdchy 85277 together with ratcliffe tailifr rq 1003 and crane. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 21 ott 1987 Consegnato il 22 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels, plant machinery and items one new ford cargo phi chassis number cc d chy 85329 registration number E647 kfb. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge without instrument | Creato il 28 ago 1984 Consegnato il 06 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H premises k/a wheeler house, colchester avenue cardiff together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the said premises. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge without instrument | Creato il 28 ago 1984 Consegnato il 06 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises k/a wheeler house, colchester avenue. Cardiff together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the said premises. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 set 1982 Consegnato il 15 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts & other debts now & from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 set 1982 Consegnato il 15 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H lying to the north west of st oswalds road, gloucester T.N. gr 48226. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 set 1982 Consegnato il 15 set 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H lying to the north west of st. Oswalds road, gloucester, T.N. gr 59540. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 20 nov 1972 Consegnato il 23 nov 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Factory and premises at abbey road, hempstead, glos. And all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage and charge | Creato il 14 dic 1959 Consegnato il 31 dic 1959 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc | |
Brevi particolari Freehold lands known as coalway lane end, nr coalway west dean, gloucs and land adjoining with buildings therein present & future undertaking and all property and present and future including uncalled capital (for details see doc 8). together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ZENITH PLUMBPOINT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0