SMILE STORES LIMITED

SMILE STORES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMILE STORES LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00641258
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di SMILE STORES LIMITED?

    • Commercio al dettaglio in negozi non specializzati con prevalenza di alimentari, bevande o tabacco (47110) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in negozi specializzati (47260) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova SMILE STORES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMILE STORES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEWSHOPS LIMITED20 ago 199820 ago 1998
    BRISTOL EVENING POST NEWSHOPS LIMITED31 mar 199631 mar 1996
    KIOSKS (WEST OF ENGLAND) LIMITED04 nov 195904 nov 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMILE STORES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 nov 2021
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ago 2022
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 nov 2020

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SMILE STORES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al20 lug 2022
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma03 ago 2022
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al20 lug 2021
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per SMILE STORES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    60 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    59 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    70 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    66 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    41 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    25 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    86 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QW England a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 18 mag 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    4 pagineAM01

    Cessazione della carica di Simon Jonathan Miller come amministratore in data 24 mar 2022

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 29 nov 2020

    42 pagineAA

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Indigo Corporate Secretary Limited come segretario in data 14 mar 2022

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Rachel Peat come segretario in data 14 mar 2022

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Mark James Crampton come amministratore in data 14 gen 2022

    1 pagineTM01

    legacy

    140 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 006412580059, creata il 26 feb 2021

    80 pagineMR01

    Modifica dei dettagli di Key Food Stores Limited come persona con controllo significativo il 09 dic 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP United Kingdom a Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QW in data 09 dic 2020

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 24 nov 2019

    37 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SMILE STORES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh On Sea
    Monometer House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione13253973
    281695990002
    BUTLER, Stuart Clive
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director127794710001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer187907210001
    MCEWAN, Karen Anita
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishColleague And Operations Director272054760001
    AMESBURY, Richard John
    9 Pemberton Court
    Fishponds
    BS16 5BJ Bristol
    Segretario
    9 Pemberton Court
    Fishponds
    BS16 5BJ Bristol
    BritishDirector81763590001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Segretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    BritishDirector88269280005
    PEAT, Rachel
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Segretario
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    256014100001
    POULTER, Gregg
    Alderley 28 Robin Lane
    Walton St Mary
    BS21 7ET Clevedon
    Somerset
    Segretario
    Alderley 28 Robin Lane
    Walton St Mary
    BS21 7ET Clevedon
    Somerset
    BritishDirector57429690001
    SYMONDS, Jeremy Paul
    Wilkinthroop House
    Horsington
    BA8 0DE Templecombe
    Somerset
    Segretario
    Wilkinthroop House
    Horsington
    BA8 0DE Templecombe
    Somerset
    BritishBa22 8dn17171810005
    VICKERY, Arthur Patrick
    Roseneath Keynsham Road
    Willsbridge
    BS30 6EN Bristol
    Segretario
    Roseneath Keynsham Road
    Willsbridge
    BS30 6EN Bristol
    British14152250001
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Segretario
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237937740001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector107991420002
    AMESBURY, Richard John
    9 Pemberton Court
    Fishponds
    BS16 5BJ Bristol
    Amministratore
    9 Pemberton Court
    Fishponds
    BS16 5BJ Bristol
    BritishFinancial Director81763590001
    BELL, Robbie Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishChief Financial Officer97384120002
    CALLAWAY, Mark Steven
    Jersey Farm House, 1 Church Road
    Heywood
    BA13 4LP Westbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Jersey Farm House, 1 Church Road
    Heywood
    BA13 4LP Westbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishDirector12548660002
    CLARKE, Stanley George Gurney
    51a Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    51a Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishCompany Director10294420001
    CRAMPTON, Richard Mark James
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Amministratore
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    United KingdomBritishChief Commercial Officer270535630001
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector181763320002
    GAY, Michael John
    The Bow
    Loxton
    BS26 2XG Axbridge
    Somerset
    Amministratore
    The Bow
    Loxton
    BS26 2XG Axbridge
    Somerset
    BritishManaging Director14152260001
    GOODE, Alan Raymond
    Honeywell Cottage
    Honeywell Lane Chewton Mendip
    BA3 4LY Bath
    North Somerset
    Amministratore
    Honeywell Cottage
    Honeywell Lane Chewton Mendip
    BA3 4LY Bath
    North Somerset
    United KingdomBritishGroup Chief Executive40618020001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritishDirector209349290001
    GRIFFIN, Thomas Allen Henry
    The Leas
    Stanton Drew
    BS18 4EJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    The Leas
    Stanton Drew
    BS18 4EJ Bristol
    Avon
    BritishDirector15039390001
    HAZELTON, Michael Robert
    84 Dorset Way
    Yate
    BS17 5SP Bristol
    Avon
    Amministratore
    84 Dorset Way
    Yate
    BS17 5SP Bristol
    Avon
    BritishOperations Director15039400001
    HUDSON, Richard Derek
    1 Greyfield View
    Temple Cloud
    BS18 5DL Bristol
    Amministratore
    1 Greyfield View
    Temple Cloud
    BS18 5DL Bristol
    BritishDirector36041430004
    KEARNEY, Paul Kevin Michael
    156 Falcondale Road
    Westbury -On -Trym
    BS9 3JF Bristol
    Amministratore
    156 Falcondale Road
    Westbury -On -Trym
    BS9 3JF Bristol
    BritishNewspaper Director34347890002
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Amministratore
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector147052660001
    MARWOOD, Jeremy Charles
    4 The Pound Court
    Dinder
    BA5 3PR Wells
    Somerset
    Amministratore
    4 The Pound Court
    Dinder
    BA5 3PR Wells
    Somerset
    BritishRetail Md66596150001
    MASON, John
    Lane House
    Southdown Road
    SO21 2BY Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Lane House
    Southdown Road
    SO21 2BY Winchester
    Hampshire
    BritishDirector106534020001
    MCBEATH, Leslie
    158 Somerset Avenue
    Yate
    BS17 5SL Bristol
    Avon
    Amministratore
    158 Somerset Avenue
    Yate
    BS17 5SL Bristol
    Avon
    BritishDirector15039410001
    MILLER, Simon Jonathan
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    Amministratore
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    England
    EnglandBritishDirector88269280005
    NEWMAN, John Richard
    Ashcroft
    College Road
    BA1 5RY Lansdown
    Bath
    Amministratore
    Ashcroft
    College Road
    BA1 5RY Lansdown
    Bath
    United KingdomBritishDirector9202380005
    POULTER, Gregg
    Alderley 28 Robin Lane
    Walton St Mary
    BS21 7ET Clevedon
    Somerset
    Amministratore
    Alderley 28 Robin Lane
    Walton St Mary
    BS21 7ET Clevedon
    Somerset
    United KingdomBritishDirector57429690001
    SADLER, Keith John
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    Amministratore
    12 Parrys Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TT Bristol
    Avon
    BritishFinance Director73173100006
    SIMPSON, Christopher David
    136 Green Lane
    HA6 1AN Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    136 Green Lane
    HA6 1AN Northwood
    Middlesex
    BritishManaging Director15039420001
    SYMONDS, Alan Jeffrey
    Portleigh 180 Somerton Road
    BA16 0SB Street
    Somerset
    Amministratore
    Portleigh 180 Somerton Road
    BA16 0SB Street
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director8295370001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SMILE STORES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    One London Road
    CM14 4QW Brentwood
    Ground Floor West
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03387234
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SMILE STORES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 feb 2021
    Consegnato il 08 mar 2021
    In corso
    Breve descrizione
    All current and future land (except for any restricted land) and intellectual property (except for any restricted ip) owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture") and including, amongst others, property at livingstone way, taunton, TA2 6BD with title number ST237070. For more details please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited Acting as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 mar 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2020
    Consegnato il 05 mar 2020
    In corso
    Breve descrizione
    All current and future land and intellectual property (except for any restricted land or restricted ip) owned by the company as specified and defined in the debenture as registered by this MR01 including, amongst others, land at taunton, livingstone way, TA2 6BD.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 05 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 lug 2016
    Consegnato il 20 lug 2016
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Secured Parties (Each as Defined in the Instrument))
    Transazioni
    • 20 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Group debenture
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 27 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the other mezzanine secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, cash collateral accounts and all monies standing to the credit of the cash collateral accounts, all plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cavendish Security Trustee Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transazioni
    • 27 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 22 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee and/or the other senior secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, cash collateral accounts and all monies standing to the credit of the cash collateral accounts, all plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 22 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Accession agreement
    Creato il 12 set 2007
    Consegnato il 21 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Now Known as Bank of Scotland PLC) in Itscapacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Acquisito il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due
    Brevi particolari
    L/H property k/a warrenstown costly street ivybridge t/no DN354648. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 71-73 fore street kingsbridge t/n DN517416. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    32 high street weston-super-mare somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 112 union street torquay t/n DN305984. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H unit 3 bindon road taunton somerset t/n ST237070. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H ground floor and basement 26 high street ilfracombe. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H ground floor 6 & 6A the boulevard weston-super-mare somerset t/n ST236819. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 155-157 st marychurch road plainmoor torquay. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 12-13 the quay bideford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 32 queen street newton abbot t/n DN358658. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H warrenstown costly street ivybridge t/n DN354648. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 47 notte street plymouth devon t/n DN288985. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 2 the strand torquay t/n DN158558. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 1 & 1A pines road marley gardens estate exmouth devon t/n DN514429. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 53 glenthorne avenue yeovil somerset t/n WS31935. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 40-42 lyde road yeovil somerset t/n WS31944. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 264-266 north street bedminster t/n BL78847. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 13 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H potters country market west hill ottery st mary east devon t/n DN494141. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 2006
    Consegnato il 16 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Allens stores south road brean somerset t/no ST241981. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SMILE STORES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2022Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Rachael Wilkinson
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire
    Praticante
    3 Forbury Place 23 Forbury Road
    RG1 3JH Reading
    Berkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0