DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED

DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDIAGONAL SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00643333
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Mansion House
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    Berks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MFT COMPUTER SYSTEMS LIMITED28 ago 198628 ago 1986
    MFT COMPUTERS LIMITED30 nov 195930 nov 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2012

    Stato del capitale al 10 ott 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Paul Grossman il 07 lug 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Nicholas Paul Grossman il 04 ott 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Guy Stuart Hodges come amministratore in data 23 apr 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Forster come amministratore in data 23 apr 2012

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    18 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Derek Burt il 20 set 2011

    3 pagineCH01

    Stato del capitale al 16 mag 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 12/05/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Terence William Burt il 22 feb 2011

    2 pagineCH01

    legacy

    38 pagineMG01

    legacy

    10 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 04 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Profile West 950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9EE in data 01 ott 2010

    2 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreements 19/07/2010
    RES13

    Chi sono gli amministratori di DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    The Mansion House
    Berks
    Segretario
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    The Mansion House
    Berks
    British152283160001
    BURT, Simon Derek
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    Amministratore
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    EnglandBritishDirector115791650002
    BURT, Terence William
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    Amministratore
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director73890540004
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    The Mansion House
    Berks
    Amministratore
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    The Mansion House
    Berks
    EnglandBritishManager157544150003
    BIRKETT, Joseph William
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director2077830001
    CAMERON, Lee John Harcourt
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    Segretario
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary76251460003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    Segretario
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    BritishSolicitor135246350002
    CHRISTOPHOROU, Steven Richard
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    Segretario
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    BritishSolicitor132483000001
    COCKS, Richard Edward Lucas
    11 Greystead Park
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    Segretario
    11 Greystead Park
    GU10 4NB Farnham
    Surrey
    BritishAccountant84725070001
    FARRELLY, Ian Brian
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    Segretario
    Park Avenue
    GU15 2NG Camberley
    20
    Surrey
    British71425280002
    HARRISON, Helen Janet
    8 Owlett Mead Close
    Thorpe
    WF3 3DL Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    8 Owlett Mead Close
    Thorpe
    WF3 3DL Wakefield
    West Yorkshire
    British12345000003
    JOWETT, Julie
    9 Coverley Rise
    Yeadon
    LS19 7WB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Coverley Rise
    Yeadon
    LS19 7WB Leeds
    West Yorkshire
    British54298560001
    NORTON, Colin Frederick
    Almonds Farm
    Moss Side Lane Great Eccleston
    PR3 0US Preston
    Lancashire
    Segretario
    Almonds Farm
    Moss Side Lane Great Eccleston
    PR3 0US Preston
    Lancashire
    British1505890001
    SANDISON, Nicholas Andrew Macdonald
    Cottage Farm Lodge
    Aylesbury Road
    HP16 9LS Great Missenden
    Buckinghamshire
    Segretario
    Cottage Farm Lodge
    Aylesbury Road
    HP16 9LS Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishLegal Counsel100721440001
    ANDREWS, Martin John
    8 Dale Meadow Close
    Balsall Common
    CV7 7QB Coventry
    Amministratore
    8 Dale Meadow Close
    Balsall Common
    CV7 7QB Coventry
    BritishDirector92737590001
    BADGER, Andrew
    24 Coldstream Road
    CR3 5ZA Caterham
    Surrey
    Amministratore
    24 Coldstream Road
    CR3 5ZA Caterham
    Surrey
    BritishOperations Director116097880001
    BERESFORD, David Michael
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector136196730001
    BIRKETT, Joseph William
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director2077830001
    BIRKETT, Joseph William
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Birchetts Crocknorth Road
    East Horsley
    KT24 5TG Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director2077830001
    BURNSIDE, Colin Drummond
    Tudor Lodge
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7UU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Tudor Lodge
    Clandon Road, West Clandon
    GU4 7UU Guildford
    Surrey
    EnglandBritishDirector87083280001
    CAMERON, Lee John Harcourt
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary76251460003
    CRESWICK, Graham Michael
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Fairview Farmhouse
    Brackenthwaite Lane Pannal
    HG3 1PL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector93409870001
    CRUICKSHANK, Stuart
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    Amministratore
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    EnglandBritishAccountant114599790001
    DODD, Eric Stephen
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    Amministratore
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Finance Director113939500001
    EMMETT, Michael Patrick Cheere
    Leatherhead Road
    Oxshott
    KT22 0ET Leatherhead
    Whitegates
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Leatherhead Road
    Oxshott
    KT22 0ET Leatherhead
    Whitegates
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanManaging Director136923570001
    FILLER, David James
    4 Avon Garth
    Linton Lane
    LS22 6HH Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Avon Garth
    Linton Lane
    LS22 6HH Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishSales And Marketing Director93409910001
    FLEMING, Steve
    96 Netherby Park
    Queens Road
    KT13 0AG Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    96 Netherby Park
    Queens Road
    KT13 0AG Weybridge
    Surrey
    BritishGroup Finance Director79487980001
    FLETCHER, James Ward
    Church Cottage
    Church Lane, Lacey Green
    HP27 0QX Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Church Cottage
    Church Lane, Lacey Green
    HP27 0QX Princes Risborough
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director67144320001
    FORSTER, Simon Andrew
    Lynwood Gelderd Road
    LS27 7LX Gildersome
    Leeds
    Amministratore
    Lynwood Gelderd Road
    LS27 7LX Gildersome
    Leeds
    United KingdomBritishDirector175037730002
    GURNEY, Simon John Okey
    Sleepy Hollow
    Bagshot Road
    GU3 3PX Worplesdon
    Surrey
    Amministratore
    Sleepy Hollow
    Bagshot Road
    GU3 3PX Worplesdon
    Surrey
    United KingdomBritishDirector6125390001
    HARRISON, Helen Janet
    8 Owlett Mead Close
    Thorpe
    WF3 3DL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    8 Owlett Mead Close
    Thorpe
    WF3 3DL Wakefield
    West Yorkshire
    BritishAccountant12345000003
    HODGES, Guy Stuart
    The Coach House
    14 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Coach House
    14 Quarry Dene
    LS16 8PA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector54298610004
    HODGES, Stuart Arthur
    26 Long Meadows
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    26 Long Meadows
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RX Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector30167150003
    HUNTER, Alan Thomas Ferguson
    Flinders Cottage
    HP3 0PW Flaunden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Flinders Cottage
    HP3 0PW Flaunden
    Hertfordshire
    BritishCompany Director72625600001
    KEEN, Nigel John
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    Amministratore
    19 Pembroke Square
    W8 6PA London
    EnglandBritishCompany Director166130001

    DIAGONAL SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A confirmatory debenture
    Creato il 02 feb 2011
    Consegnato il 14 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 14 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 14 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 30 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, credit balances, insurances and other contracts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 30 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 28 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 28 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 12 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 31 mag 1994
    Consegnato il 09 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or sovco (559) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1994
    Consegnato il 07 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Enterprise Fund for Yorkshire and Humberside
    Transazioni
    • 07 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 giu 1991
    Consegnato il 28 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 20/6/91
    Brevi particolari
    The property and assets of the business comprising a) the goodwill b) the intellectual property c) the fixed assets (for full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Zelix Corporation Limited
    Transazioni
    • 28 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 1990
    Consegnato il 03 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Co.
    Transazioni
    • 03 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 25 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ago 1989
    Consegnato il 06 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 06 giu 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0