OVERLEY PROPERTIES LIMITED

OVERLEY PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOVERLEY PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00643543
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OVERLEY PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova OVERLEY PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Fisher Partners Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OVERLEY PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per OVERLEY PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2016

    3 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2015

    3 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Heron House 4 Bentinck Street London W1U 2EF a Fisher Partners Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER in data 18 ago 2014

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Stato del capitale al 17 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Jonathan Goldstein come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Daniel Simon Samson come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Lionel Harvey Zeltser il 27 set 2010

    2 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Simon Goldstein il 27 set 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Heron House 19 Marylebone Road London NW1 5JL* in data 04 ott 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Gerald Maurice Ronson il 27 set 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OVERLEY PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ZELTSER, Lionel Harvey
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Segretario
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    British82318190001
    RONSON, Gerald Maurice, Sir
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector33068600002
    SAMSON, Daniel Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor183982890001
    BROWN, Steven Andrew
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    Segretario
    36 St Marys Avenue
    N3 1SN London
    British107162240001
    FENCHELLE, Mark Stephen
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    Segretario
    7 Bovill Road
    Honor Oak Park
    SE23 1HB London
    British40682770001
    HAMPTON, Sarah Isabel
    The Garden Flat
    9 Hobury Street
    SW10 0JB Chelsea
    London
    Segretario
    The Garden Flat
    9 Hobury Street
    SW10 0JB Chelsea
    London
    British37785670001
    MORTON, Christopher John
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    Segretario
    8 Wighton Mews
    TW7 4DZ Isleworth
    Middlesex
    British71879280001
    PARSONS, Neil
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    Segretario
    12 The Warren
    SM5 4EH Carshalton
    Surrey
    British67799270001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director8958700001
    GOLDSTEIN, Jonathan Simon
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Bentinck Street
    W1U 2EF London
    Heron House
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor68352140004
    HOWSON, Roger Clive
    34 Long Buftlers
    AL5 1JE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    34 Long Buftlers
    AL5 1JE Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director104957540007
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritishCompany Director153028260001
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Amministratore
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritishAccountant50761250001

    OVERLEY PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 08 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Trust Company Limited as Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 08 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alnery No. 1283 Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 08 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    95. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Ssc Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 08 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    95. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Trustee on Behalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 08 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 11 apr 1991
    Consegnato il 19 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of rights the loan facility dated 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge over all the company's right, title and interest in the agreements, warranties, undertakings, copyrights and rights (see doc M167 for details of the agreements).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust & Savings Association.
    Transazioni
    • 19 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 ott 1990
    Consegnato il 09 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of the loan facility in accordance with the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and any variation thereto and this deed
    Brevi particolari
    F/H units 1 & 2 wesley gate, reading berks title nos bk 270697 and bk 122355 and the agreements specified on form M395, ref 177.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 09 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 13 lug 1990
    Consegnato il 24 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and any other agreements as defined.
    Brevi particolari
    68-82 queens road reading berkshire and all rights and benefits in the agreements and contracts specified on form M395, ref M231.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 24 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 apr 1990
    Consegnato il 27 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and this deed.
    Brevi particolari
    Land on the south side of eastern by-pass road littlemore oxford. Title no on 127740 land now k/a "heritage gate" title no on 43833. together with all buildings and other structures. All rights title and interest in the agreements specified on form M395, ref M259.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 27 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 17 gen 1990
    Consegnato il 29 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a loan facility, the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and any other agreement ad defined
    Brevi particolari
    All right, title and interest in land known as 74 college road land on borough of harrow (formerly known as "the roxborough hotel public house") title no mx 479068 all agreements, contracts, proceeds of sale, undertakings etc (see doc 204 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 29 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 17 gen 1990
    Consegnato il 29 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a loan facility the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and any other agreement as defined
    Brevi particolari
    All right, title and interest in land known as 2-4 middleton road, banbury, oxfordshire title no 127047 all agreements, contracts, proceeds of sale, undertakings etc (see doc M201 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 29 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 17 gen 1990
    Consegnato il 29 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a loan facility the umbrella facility agreement dated 31/3/88 and any other agreement as defined
    Brevi particolari
    All right, title and interest in land known as heritage gate being land on the south side of eastern by-pass road, littlemore, oxford, oxfordshire title no on 43833 all agreements, contracts, proceeds of sale, undertakings etc (see doc M198 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 29 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 22 nov 1988
    Consegnato il 28 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the loan agreement and the facility request as defined in the deed
    Brevi particolari
    All the company's beneficial interest in part of phase ii weyside park, cattershall, godalming title no sy 456330 assignment of all rights, title and interest and benefit in any agreements or warranties (see doc M295 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America Nt&Sa
    Transazioni
    • 28 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 18 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America Nt&Sa
    Transazioni
    • 18 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 19 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Land on the north side of the causeway staines, runnymeade, surrey T.N. sy 555182 (please see form 395 serial no. M317 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 19 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1992Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 19 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Part of the property k/a phase ii weyside park catteshall lane godalming, waverley surrey T.N. sy 578010 (please see form 395 N. M320 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 19 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 19 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Land on the west side of brighton road, crawley west sussex T.N. wsx 123632 (please see form 395 serial no. M323 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 19 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1992Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 18 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge each drawings bank account bank account opened by the borrower with the mortgagee in respect of any said loan facility.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 18 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 18 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over each revenues bank account opened by the borrower with the mortgagee in respect of any said loan facility.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 18 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 29 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 19 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of an umbrella facility agreement d/d 31/3/88 and this charge
    Brevi particolari
    Land on the north side at catteshall lane godalming waverley surrey T.N. sy 565442 (please see form 395 serial no M314 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bank of America National Trust and Savings Association.
    Transazioni
    • 19 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    OVERLEY PROPERTIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 giu 2014Inizio della liquidazione
    14 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0