SITE IMPROVEMENTS LIMITED

SITE IMPROVEMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSITE IMPROVEMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00643984
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SITE IMPROVEMENTS LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova SITE IMPROVEMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SITE IMPROVEMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SITE IMPROVEMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineLIQ14

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2017

    2 pagine3.6

    Cessazione della carica di Reit (Corporate Services) Limited come segretario in data 08 ago 2017

    2 pagineTM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2017

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2017

    20 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2016

    2 pagine3.6

    Cessazione della carica di Christopher George White come amministratore in data 11 apr 2016

    2 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2016

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2016

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2015

    2 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2015

    18 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2015

    2 pagine3.6

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Begbies Traynor 32 Cornhill London EC3V 3BT England a 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 26 set 2014

    2 pagineAD01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2014

    2 pagine3.6

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2014

    18 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2014

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2013

    3 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2013

    19 pagine4.68

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2013

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 ago 2012

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 07 feb 2012

    3 pagine3.6

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 gen 2012

    17 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di SITE IMPROVEMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Segretario
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Segretario
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Amministratore
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LONGMAN, Karen Sarah
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    Amministratore
    14b Alexandra Mansions
    West End Lane
    NW6 1LU London
    British29163610001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish80132540006
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    SITE IMPROVEMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Twelfth supplemental trust deed
    Creato il 15 set 2006
    Consegnato il 18 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general limited and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land known as pinvin works station road pershore t/n WR55163, the f/h land known as land and buildings on the south side of abbey view road pershore t/n WR53887 the l/h land known as polestar newspac unit abbey view road pershore t/n WR57160,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Irg Trustees Limited
    Transazioni
    • 18 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 210 feb 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 210 giu 2014Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 210 giu 2014Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 2
    Debenture
    Creato il 15 set 2004
    Consegnato il 29 set 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 29 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 06 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental debenture
    Creato il 24 ago 1998
    Consegnato il 25 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Brevi particolari
    F/H land k/a river west house 23 eyot gardens hammersmith london W6 xios house eyot gardens and 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 42A, 42B, 42C and 42E grove terrace hammersmith t/n-NGL462795 together with the proceeds of sale of the same together with any property and land already charged to the security trustee by way of legal mortgage by the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 04 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brevi particolari
    Please see doc M36 for details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Banks
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a the high street shopping centre high street gorleston norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 nov 1990
    Consegnato il 13 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property k/a river west house, 23 eyot gardens london W4. Title number ngl 462795 tog with all buildings and fixtures. By way of assignment the goodwill (if any) of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable mortgage
    Creato il 02 nov 1990
    Consegnato il 08 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates & general PLC. Under the terms of the charge to the chargee.
    Brevi particolari
    Beacon 27 southampton rd. Eastleigh hampshire being (a) f/h property at 84,86 and 90-98 (even) southampton rd eastleigh hampshire. Title number hp 184884 and l/h property k/a the back of 84 and 86 southampton road, eastleigh hampshire. Title number hp 237371.
    Persone aventi diritto
    • Commerzbank A.G. London Branch
    Transazioni
    • 08 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge
    Creato il 10 ago 1990
    Consegnato il 31 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates and general PLC and from the company. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Equitable charge over the precinct high street gorleston.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge by deposit of title deeds.
    Creato il 26 lug 1988
    Consegnato il 27 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from estates and general investments PLC. To the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a the polygon fourth way avonswith.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 10 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental trust deed
    Creato il 28 apr 1987
    Consegnato il 08 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18,000,000 11.25 per cent first mortgage debenture stock 2018 & the £3,000,000 12.4 per cent first mortgage debenture stock 2018 of estates and general investments PLC & all other moneys intended to be secured as defined in the principal trust deed dated 21/12/83 & deeds suplemental thereto
    Brevi particolari
    F/H property river west house, 23 egot gardens, l/b of hammersmith & fulham (title n l: ngl 462795) etc together with all bldgs, erections, fixtures etc (see doc M150/8 may/ln for full details).
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1991Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 giu 1995Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1965
    Consegnato il 23 dic 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £225,000
    Brevi particolari
    The G.E.M. supercentre, cross gates road, cros gates leeds (see doc. 28).
    Persone aventi diritto
    • Pearl Assurance Co LTD
    Transazioni
    • 23 dic 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SITE IMPROVEMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 gen 2011Inizio della liquidazione
    21 mag 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Praticante
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore/gestore
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore/gestore
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ricevitore/gestore
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0