MPG LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMPG LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00645892
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MPG LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova MPG LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BAKER TILLY
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MPG LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STAPLES PRINTERS LIMITED31 dic 195931 dic 1959

    Quali sono gli ultimi bilanci di MPG LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per MPG LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2018

    6 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2018

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2017

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2017

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2016

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2016

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2015

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2015

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2014

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2014

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2013

    10 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2013

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2012

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2012

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 ago 2011

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2011

    7 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5 Old Bailey London EC4M 7AF* in data 29 nov 2010

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 feb 2010

    15 pagine2.24B

    Nomina di un liquidatore volontario

    5 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 feb 2010

    15 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine2.34B

    Chi sono gli amministratori di MPG LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Clive Haydn, Sir
    Weatherbury
    16 Heath Road
    EN6 1LN Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Weatherbury
    16 Heath Road
    EN6 1LN Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishPrinter7690350001
    MARTIN, Linda Constance, Lady
    Weatherbury
    16 Heath Road
    EN6 1LJ Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Weatherbury
    16 Heath Road
    EN6 1LJ Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishCompany Director9187670001
    MILTON, Michael Robin
    Willowhayne House
    Tamarisk Way The Willowhayne
    BN16 2TE East Preston
    West Sussex
    Amministratore
    Willowhayne House
    Tamarisk Way The Willowhayne
    BN16 2TE East Preston
    West Sussex
    EnglandBritishChief Executive9149150004
    HARDACRE, Eian Clark
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    Segretario
    6 Wilcot Close
    Bisley
    GU24 9DE Woking
    Surrey
    BritishDirector119450490001
    HICKFORD, Colin James
    23 Thornash Close
    Horsell
    GU21 4UP Woking
    Surrey
    Segretario
    23 Thornash Close
    Horsell
    GU21 4UP Woking
    Surrey
    British27692940001
    MARTIN, Thomas Alexander Haydn
    Merrythought
    Dirtham Lane
    KT24 5SD Effingham
    Surrey
    Segretario
    Merrythought
    Dirtham Lane
    KT24 5SD Effingham
    Surrey
    British87897080001
    MARTIN, Thomas Alexander Haydn
    Merrythought
    Dirtham Lane
    KT24 5SD Effingham
    Surrey
    Segretario
    Merrythought
    Dirtham Lane
    KT24 5SD Effingham
    Surrey
    British87897080001
    MILTON, Michael Robin
    Tudor Court Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    Tudor Court Finch Lane
    Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British9149150001
    NARIS, Grant
    6 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    6 Springfield
    GU18 5XP Lightwater
    Surrey
    EnglandBritishFinancial Controller64210190002
    NARIS, Grant
    74 Hawkesworth Drive
    GU19 5QZ Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    74 Hawkesworth Drive
    GU19 5QZ Bagshot
    Surrey
    BritishFinancial Controller64210190001
    POWELL SMITH, Christopher Brian
    32 The Avenue
    Kew
    TW9 2AJ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    32 The Avenue
    Kew
    TW9 2AJ Richmond
    Surrey
    BritishSolicitor2430270001
    QUINNEY, John
    Button Hide Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Button Hide Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    BritishPrinter9149160001

    MPG LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 dic 2006
    Consegnato il 23 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 set 2005
    Consegnato il 14 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 nov 1998
    Consegnato il 21 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 21 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mag 1987
    Consegnato il 14 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 18 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 30 set 1985
    Consegnato il 08 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold premises forming the west part of a building at gads hill gillingham, kent l/hold premises at 94/96 wigmore street, london W7 (see doc M97 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 08 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 giu 1965
    Consegnato il 06 lug 1965
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £350,000 and all other sums due etc.
    Brevi particolari
    Numbers 14 and 16, love lane, land and buildings on west side of st margarets street and land on west side of love lane - all at rochester, kent comprised in title no. K91535 land on north east side of london road in parish of st peters, st albans, hereford known as priory press.
    Persone aventi diritto
    • Credit for Industry LTD
    Transazioni
    • 06 lug 1965Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MPG LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 lug 2009Inizio dell'amministrazione
    17 feb 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    2
    DataTipo
    17 feb 2010Inizio della liquidazione
    13 nov 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Bruce Alexander Mackay
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Matthew Robert Haw
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0