MONITOR HOLIDAYS LIMITED

MONITOR HOLIDAYS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMONITOR HOLIDAYS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00646236
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 feb 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    0 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 feb 2012

    • Capitale: GBP 10,000
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 16/02/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Rank Nemo (Twenty-Six) Limited il 05 set 2011

    1 pagineCH04

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 21 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Frances Bingham il 01 mar 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MONITOR HOLIDAYS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THE RANK ORGANISATION LIMITED
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    116576210002
    BINGHAM, Frances
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Statesman House
    Stafferton Way
    SL6 1AY Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish128838610001
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Segretario
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    Segretario
    91a Crystal Palace Road
    SE22 9EY London
    British71005690004
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Segretario
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    British108784710001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Segretario
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002
    COLES, Pamela Mary
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    36 London End
    HP9 2JH Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British70326980002
    CORMICK, Charles Bruce Arthur
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    Amministratore
    Flat 2
    11 Pembridge Crescent
    W11 3DT London
    United KingdomBritish17946190001
    DE MIGUEL, Fiona Margaret
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Brace Close
    Cheshunt
    EN7 6WY Waltham Cross
    Hertfordshire
    British42996540002
    DOCKRELL, Carol Ann
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    Amministratore
    77 St Marys Drive
    SS7 1LH Benfleet
    Essex
    British26244410001
    DUFFILL, Clare Marianne
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    Amministratore
    25 Landells Road
    SE22 9PG London
    British71005690005
    PATEL, Aurelia Azalea
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    Amministratore
    50 Windsor Road
    RM8 3LA Dagenham
    Essex
    British108784710001
    THOMAS, Francis George Northcott
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Sandfield Cottage
    St Nicolas Lane
    BR7 5LL Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish34191470001
    WATKINS, Simon Andrew
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    Amministratore
    26 Pleasant Drive
    CM12 0JL London
    British34048840002

    MONITOR HOLIDAYS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 28 nov 1988
    Consegnato il 09 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mecca leisure group PLC to the chargee, under the terms of the loan agreement dated 15/11/88
    Brevi particolari
    Undertaking and al property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montague & Co Limited as Security and Trustee Agent for the Bank.
    Transazioni
    • 09 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 dic 1987
    Consegnato il 11 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co limited as agent for itself and the chargees under the terms of a loan agreement dated 29/12/87
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over f/hold and l/hold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and the benefit of all securities undertaking, property, rights and assets both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Charterhouse Bank Limited
    • Samuel Montague & Co Limited
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • Credit Lyonnais Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 15 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from mecca leisure group PLC to samuel montagu & co limited as agent for itself and trustee for midland bank PLC, charterhouse bank limited and the royal bank of scotland PLC under the terms of the loan agreement dated 7/11/86
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and other sums, undertakings rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montague Co. Limited, Midland Bank PLC, Charterhouse Bank Limited
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 15 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (including all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all bents and otehr sums, undertakings rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 mag 1987
    Consegnato il 15 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all freehold and leasehold property (uncluding all fittings, fixtures, fixed plant and machinery thereon) all debts and other sums, undertakings rights and assets.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 28 lug 1986
    Consegnato il 01 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £20,000,000 11.5% debenture stock 2011 of mecca leisure group PLC and all other moneys intended to be secured by the said trust deed.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future (including uncalled capital) of the company by way of first floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 01 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Equitable charge without written instrument.
    Creato il 17 feb 1986
    Consegnato il 21 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing guarantee of the principal amount and premises (if any) and interest in respect of the 11 1/2 per cent. Debenture stock 2011 of mecca leisure group PLC ("the stock)" and all other moneys intended to be secured by or payable under or pursuant to a trust deed constituting and securing the stock.
    Brevi particolari
    Of the company by way of floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 21 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 dic 1985
    Consegnato il 20 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing all monies due or to become due from mecca leisure group limited to samuel montague & co limited as agent for itself and the other banks under the terms of a loan agreement dated 16/12/1985.
    Brevi particolari
    . for further details see doc M81.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montague & Co. Limited as Agent for Itself and the Other Banks.
    Transazioni
    • 20 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 02 giu 1972
    Consegnato il 09 giu 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Further securing £750,000 debenture stock of monitor holidays LTD. Secured by a trust deed dated 30/11/64
    Brevi particolari
    Undertaking and floating charge all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchaange Assurance
    Transazioni
    • 09 giu 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MONITOR HOLIDAYS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2013Data di scioglimento
    24 feb 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0