PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00649213 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Salters Lane TS21 3EE Sedgefield County Durham United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TENNECO PACKAGING (CAERPHILLY) LIMITED | 03 dic 1996 | 03 dic 1996 |
| DELYN PACKAGING LIMITED | 28 mar 1991 | 28 mar 1991 |
| DELYN PLASTICS LIMITED | 22 mar 1988 | 22 mar 1988 |
| DELYN PAPER MILLS LIMITED | 11 feb 1960 | 11 feb 1960 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da South Denes Road Great Yarmouth Norfolk NR30 3QF a Salters Lane Sedgefield County Durham TS21 3EE in data 28 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di John Mcgrath come amministratore in data 01 ago 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Michelle Mosier come amministratore in data 01 ago 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Charles Shanahan come amministratore in data 01 ago 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Steven Karl come segretario in data 01 ago 2013 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jay Scott Barnes come segretario in data 31 mar 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 13 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Charles Shanahan il 12 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Joseph Edward Doyle il 12 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jay Scott Barnes il 12 giu 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 6 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARL, Steven | Segretario | TS21 3EE Sedgefield Salters Lane County Durham United Kingdom | 181154320001 | |||||||
| DOYLE, Joseph Edward | Amministratore | TS21 3EE Sedgefield Salters Lane County Durham United Kingdom | United States | American | 129040040001 | |||||
| MCGRATH, John | Amministratore | TS21 3EE Sedgefield Salters Lane County Durham United Kingdom | United States | American | 181146430001 | |||||
| MOSIER, Michelle | Amministratore | TS21 3EE Sedgefield Salters Lane County Durham United Kingdom | United States | American | 181158870001 | |||||
| ALLEN, Kenneth Dale | Segretario | 97 Eaton Terrace SW1W 8TW London | American | 42924090001 | ||||||
| BARNES, Jay Scott | Segretario | South Denes Road Great Yarmouth NR30 3QF Norfolk | British | 108969550001 | ||||||
| BATEY, Kevin William | Segretario | 24 Denewood Forest Hall NE12 7FA Newcastle Tyne & Wear | British | 76066220001 | ||||||
| LUCHERINI, Roberto | Segretario | 47 Hillsden Road NE25 9XF Whitley Bay Tyne & Wear | British | 11579490001 | ||||||
| WEBER, John Stuart | Segretario | 29 Woodvale Avenue Cyncoed CF23 6SP Cardiff | British | 65762610001 | ||||||
| ZERHUSEN, David Edward | Segretario | 18 Hampstead Way Hampstead Garden Suburb NW11 7LS London | American | 53681230001 | ||||||
| ALLEN, Kenneth Dale | Amministratore | 97 Eaton Terrace SW1W 8TW London | American | 42924090001 | ||||||
| BRAUN, Malcolm | Amministratore | 5 St Fagans Drive St Fagans CF5 6EF Cardiff South Glamorgan | British | 13509790001 | ||||||
| BRUSH, David Paul | Amministratore | 1043 Mcglinnin Ct Lake Forest Illinois Il60045-1553 United States | American | 66863300002 | ||||||
| COATES, Peter Charles | Amministratore | Glas Lyn Cwrt Cefn Mill Road Lisvane CF4 5US Cardiff | British | 41918630001 | ||||||
| GRAY, Ronald Walker | Amministratore | The Garden House Spylaw Bank Road EH13 9JD Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 52762430001 | |||||
| GREEN, Cyril Joseph | Amministratore | 15 Latchford Road Gayton CH60 3RN Wirral Merseyside | United Kingdom | British | 76066290001 | |||||
| GRISWOLD, Paul John | Amministratore | 11 Pembroke 60045 Lake Forest Illinois Usa | American | 42381080001 | ||||||
| JOHNSON, Graham Leslie | Amministratore | 28 Devonshire Close W1N 1LG London | British | 61431400001 | ||||||
| LEWIS, Peter | Amministratore | The Beeches West Layton DL11 7PS Richmond North Yorkshire | British | 61513940002 | ||||||
| LOWTHE, Derek William | Amministratore | 2 Balmoral Close Lisvane CF14 0EX Cardiff South Glamorgan | Wales | British | 88034480001 | |||||
| MORRIS, James | Amministratore | 309 Rothbury Court Lake Bluff Illinios 60044 Usa | American | 69310290001 | ||||||
| PENEZ, Wilfred Gerard Michael | Amministratore | 18 Barbrook Close Lisvane CF4 5XG Cardiff South Glamorgan | British | 14548360001 | ||||||
| REED, Harry | Amministratore | Garden Reach Whickham Lodge Rise Whickham NE16 4RY Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | 56415710003 | |||||
| SHANAHAN, Michael Charles | Amministratore | South Denes Road Great Yarmouth NR30 3QF Norfolk | Usa | American | 129040240001 | |||||
| TAYLOR, John Buchanan | Amministratore | Armcliffe Lynton Avenue Boston Spa LS23 6BL Wetherby West Yorkshire | British | 41918570001 | ||||||
| THOMAS, Sydney John | Amministratore | 129 Maes Glas Meadon Estate CF8 1JW Caerphilly Mid Glamorgan | British | 42949620001 | ||||||
| WEBER, John Stuart | Amministratore | 29 Woodvale Avenue Cyncoed CF23 6SP Cardiff | Wales | British | 65762610001 | |||||
| WOLF, Robert Ames | Amministratore | 570 Patriot Court Gurnee Illinois Il60031 Usa | American | 108810220001 | ||||||
| ZERHUSEN, David Edward | Amministratore | 18 Hampstead Way Hampstead Garden Suburb NW11 7LS London | American | 53681230001 |
PACTIV (CAERPHILLY) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Creato il 31 gen 1995 Consegnato il 02 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargees (as defined) on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof schedule one used kiefel automatic thermoforming machine type kl sh/76 serial no: 34.290/01. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 17 nov 1994 Consegnato il 21 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the chattels plant machinery and things as described in the schedule one used kiefel automatic thermoforming machine kl 2 sh/76 serial no: 34.290/01. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 18 lug 1991 Consegnato il 07 ago 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0