ITV BORDER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàITV BORDER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00654206
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ITV BORDER LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ITV BORDER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Itv White City
    201 Wood Lane
    W12 7RU London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ITV BORDER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BORDER TELEVISION LIMITED28 mar 196028 mar 1960

    Quali sono gli ultimi bilanci di ITV BORDER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ITV BORDER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Modifica dei dettagli di Itv Broadcasting Limited come persona con controllo significativo il 24 mag 2022

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE United Kingdom a Itv White City 201 Wood Lane London W12 7RU in data 23 mag 2022

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Helen Jane Tautz come amministratore in data 11 apr 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da The London Television Centre Upper Ground London SE1 9LT United Kingdom a 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE in data 06 giu 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ago 2015

    Stato del capitale al 26 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ITV BORDER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRVING, Eleanor Kate
    201 Wood Lane
    W12 7RU London
    Itv White City
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Wood Lane
    W12 7RU London
    Itv White City
    United Kingdom
    United KingdomBritish185037250001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Segretario
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Segretario
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    FEGAN, Michael Melvyn
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    Segretario
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    British28801550002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Segretario
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    British59245010001
    TAUTZ, Helen Jane
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Segretario
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    British37564540001
    ALLEN, Charles Lamb
    70 Woodsford Square
    W14 8DS London
    Amministratore
    70 Woodsford Square
    W14 8DS London
    British63372790009
    BRADFORD, Rachel Julia
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish175119720002
    BRAGG, Melvyn, Lord
    12 Hampstead Hill Gardens
    NW3 2PL London
    Amministratore
    12 Hampstead Hill Gardens
    NW3 2PL London
    United KingdomBritish21737580001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Amministratore
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    BURGESS, (Robin) Robert Lawie Frederick
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    British21402620001
    BURKETT, Mary Elizabeth
    Isel Hall
    CA13 Cockermouth
    Cumbria
    Amministratore
    Isel Hall
    CA13 Cockermouth
    Cumbria
    British21402630001
    BUTTERFIELD, Stewart David
    26 Gerrard Road
    N1 8AY London
    Amministratore
    26 Gerrard Road
    N1 8AY London
    British54977570001
    CANETTY CLARKE, Neil Ashley
    Horsebrooks Farm
    Williards Will
    TN19 7DB Etchingham
    East Sussex
    Amministratore
    Horsebrooks Farm
    Williards Will
    TN19 7DB Etchingham
    East Sussex
    United KingdomBritish85247640001
    CORLEY, Paul John
    Holly House
    Langley Gardens Corby Hill
    CA4 8PS Carlisle
    Amministratore
    Holly House
    Langley Gardens Corby Hill
    CA4 8PS Carlisle
    British61633470001
    CROFT, David Michael Bruce
    Shamrock Cottage
    Foxcovert Lane
    WA16 9QP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Shamrock Cottage
    Foxcovert Lane
    WA16 9QP Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish56897060002
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Amministratore
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    DAVIES, Paul Richard
    4 Park Avenue
    East Sheen
    SW14 8AT London
    Amministratore
    4 Park Avenue
    East Sheen
    SW14 8AT London
    British55332120001
    DESMOND, Michael John
    5 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0NB London
    Amministratore
    5 Copse Hill
    Wimbledon
    SW20 0NB London
    EnglandBritish31522290002
    FEGAN, Michael Melvyn
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    British28801550002
    FEGAN, Michael Melvyn
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    85 Park Road
    TW11 0AW Teddington
    Middlesex
    British28801550002
    GRAHAM, James Lowery
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    Amministratore
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    British2014530001
    GREEN, Michael Anthony
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish33864440003
    GREEN, Michael Anthony
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    70 Spurgate
    Hutton Mount
    CM13 2JT Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish33864440003
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Amministratore
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritish40917640001
    HARTLEY, Malcolm Brian
    Westville
    Tynwald Road
    ISLE MAN Peel
    Isle Of Man
    Amministratore
    Westville
    Tynwald Road
    ISLE MAN Peel
    Isle Of Man
    British23124240001
    IRVING, Eleanor Kate
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish79177030002
    IRVING, Eleanor Kate
    Plimsoll Road
    N4 2ED London
    137
    Amministratore
    Plimsoll Road
    N4 2ED London
    137
    United KingdomBritish79177030002
    JONES, Clive William
    48 Church Crescent
    Muswell Hill
    N10 3NE London
    Amministratore
    48 Church Crescent
    Muswell Hill
    N10 3NE London
    EnglandBritish112692490001
    MAXWELL STUART, Catherine Margaret Mary
    Traquair House
    EH44 6PW Innerleithen
    Peebleshire
    Amministratore
    Traquair House
    EH44 6PW Innerleithen
    Peebleshire
    ScotlandBritish1154500002
    MCCULLOCH, Ian Douglas
    Mayfield
    Knipp Hill
    KT11 2PE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Mayfield
    Knipp Hill
    KT11 2PE Cobham
    Surrey
    British72107570002
    MEDLICOTT, William Jonathan
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Upper Ground
    SE1 9LT London
    The London Television Centre
    United Kingdom
    EnglandEnglish44636500002
    MERRALL, Douglas Edward
    The Green
    Irthington
    CA6 4NJ Brampton
    Cumbria
    Amministratore
    The Green
    Irthington
    CA6 4NJ Brampton
    Cumbria
    British72835090001
    PATERSON-BROWN, June, Dr.
    Norwood
    TD9 7HP Hawick
    Roxburghshire
    Amministratore
    Norwood
    TD9 7HP Hawick
    Roxburghshire
    British735690001
    QUINN, Andrew
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    Amministratore
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    British42394270002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ITV BORDER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    201 Wood Lane
    W12 7RU London
    Itv White City
    United Kingdom
    06 apr 2016
    201 Wood Lane
    W12 7RU London
    Itv White City
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00955957
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ITV BORDER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land on the durranhill industrial estate carlisle also K.a the television centre durranhill brunel way carlisle cumbria. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 mar 1991
    Consegnato il 28 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 dic 1987
    Consegnato il 11 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18 clerkenwell close l/b of islington t/no ngl 217492 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 nov 1987
    Consegnato il 03 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land & buildings at durranhill industrial estate carlisle and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 18 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 apr 1972
    Consegnato il 03 mag 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on durranhill estate, carlisle. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0