ITV BORDER LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ITV BORDER LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00654206 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ITV BORDER LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ITV BORDER LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Itv White City 201 Wood Lane W12 7RU London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ITV BORDER LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BORDER TELEVISION LIMITED | 28 mar 1960 | 28 mar 1960 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ITV BORDER LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ITV BORDER LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Itv Broadcasting Limited come persona con controllo significativo il 24 mag 2022 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE United Kingdom a Itv White City 201 Wood Lane London W12 7RU in data 23 mag 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Jane Tautz come amministratore in data 11 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The London Television Centre Upper Ground London SE1 9LT United Kingdom a 2 Waterhouse Square 140 Holborn London EC1N 2AE in data 06 giu 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 14 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ITV BORDER LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRVING, Eleanor Kate | Amministratore | 201 Wood Lane W12 7RU London Itv White City United Kingdom | United Kingdom | British | 185037250001 | |||||
| BROWNLOW, Peter | Segretario | Quarry Bank Capon Hill CA8 1QN Brampton Cumbria | British | 4459070001 | ||||||
| CUSICK, Nicholas Jonathan Paul | Segretario | 30 Longlands Road CA3 9AD Carlisle | British | 50942120001 | ||||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Segretario | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| SCHWARZ, Nathalie Esther | Segretario | Flat 10 28 Belsize Avenue NW3 4AU London | British | 59245010001 | ||||||
| TAUTZ, Helen Jane | Segretario | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | British | 37564540001 | ||||||
| ALLEN, Charles Lamb | Amministratore | 70 Woodsford Square W14 8DS London | British | 63372790009 | ||||||
| BRADFORD, Rachel Julia | Amministratore | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 175119720002 | |||||
| BRAGG, Melvyn, Lord | Amministratore | 12 Hampstead Hill Gardens NW3 2PL London | United Kingdom | British | 21737580001 | |||||
| BROWNLOW, Peter | Amministratore | Quarry Bank Capon Hill CA8 1QN Brampton Cumbria | British | 4459070001 | ||||||
| BURGESS, (Robin) Robert Lawie Frederick | Amministratore | Hall Flatt Scaleby CA6 4LE Carlisle Cumbria | British | 21402620001 | ||||||
| BURKETT, Mary Elizabeth | Amministratore | Isel Hall CA13 Cockermouth Cumbria | British | 21402630001 | ||||||
| BUTTERFIELD, Stewart David | Amministratore | 26 Gerrard Road N1 8AY London | British | 54977570001 | ||||||
| CANETTY CLARKE, Neil Ashley | Amministratore | Horsebrooks Farm Williards Will TN19 7DB Etchingham East Sussex | United Kingdom | British | 85247640001 | |||||
| CORLEY, Paul John | Amministratore | Holly House Langley Gardens Corby Hill CA4 8PS Carlisle | British | 61633470001 | ||||||
| CROFT, David Michael Bruce | Amministratore | Shamrock Cottage Foxcovert Lane WA16 9QP Knutsford Cheshire | England | British | 56897060002 | |||||
| CUSICK, Nicholas Jonathan Paul | Amministratore | 30 Longlands Road CA3 9AD Carlisle | British | 50942120001 | ||||||
| DAVIES, Paul Richard | Amministratore | 4 Park Avenue East Sheen SW14 8AT London | British | 55332120001 | ||||||
| DESMOND, Michael John | Amministratore | 5 Copse Hill Wimbledon SW20 0NB London | England | British | 31522290002 | |||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Amministratore | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| FEGAN, Michael Melvyn | Amministratore | 85 Park Road TW11 0AW Teddington Middlesex | British | 28801550002 | ||||||
| GRAHAM, James Lowery | Amministratore | Oak House Great Corby CA4 8NE Carlisle Cumbria | British | 2014530001 | ||||||
| GREEN, Michael Anthony | Amministratore | 70 Spurgate Hutton Mount CM13 2JT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 33864440003 | |||||
| GREEN, Michael Anthony | Amministratore | 70 Spurgate Hutton Mount CM13 2JT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 33864440003 | |||||
| HARRIS, Peter Jonathan | Amministratore | 381 Wimbledon Park Road SW19 6PE London | England | British | 40917640001 | |||||
| HARTLEY, Malcolm Brian | Amministratore | Westville Tynwald Road ISLE MAN Peel Isle Of Man | British | 23124240001 | ||||||
| IRVING, Eleanor Kate | Amministratore | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| IRVING, Eleanor Kate | Amministratore | Plimsoll Road N4 2ED London 137 | United Kingdom | British | 79177030002 | |||||
| JONES, Clive William | Amministratore | 48 Church Crescent Muswell Hill N10 3NE London | England | British | 112692490001 | |||||
| MAXWELL STUART, Catherine Margaret Mary | Amministratore | Traquair House EH44 6PW Innerleithen Peebleshire | Scotland | British | 1154500002 | |||||
| MCCULLOCH, Ian Douglas | Amministratore | Mayfield Knipp Hill KT11 2PE Cobham Surrey | British | 72107570002 | ||||||
| MEDLICOTT, William Jonathan | Amministratore | Upper Ground SE1 9LT London The London Television Centre United Kingdom | England | English | 44636500002 | |||||
| MERRALL, Douglas Edward | Amministratore | The Green Irthington CA6 4NJ Brampton Cumbria | British | 72835090001 | ||||||
| PATERSON-BROWN, June, Dr. | Amministratore | Norwood TD9 7HP Hawick Roxburghshire | British | 735690001 | ||||||
| QUINN, Andrew | Amministratore | Kilnholme Penton CA6 5QZ Carlisle | British | 42394270002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ITV BORDER LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itv Broadcasting Limited | 06 apr 2016 | 201 Wood Lane W12 7RU London Itv White City United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ITV BORDER LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Creato il 31 mar 1999 Consegnato il 09 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a land on the durranhill industrial estate carlisle also K.a the television centre durranhill brunel way carlisle cumbria. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 31 mar 1999 Consegnato il 09 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 25 mar 1991 Consegnato il 28 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 29 dic 1987 Consegnato il 11 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 18 clerkenwell close l/b of islington t/no ngl 217492 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 17 nov 1987 Consegnato il 03 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a land & buildings at durranhill industrial estate carlisle and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 13 apr 1972 Consegnato il 03 mag 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on durranhill estate, carlisle. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0