COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED

COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00654550
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLLETT,DICKENSON,PEARCE INTERNATIONAL LIMITED30 mar 196030 mar 1960

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2011

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Simmons & Simmons Citypoint One Ropemaker Street London EC2Y 9SS in data 12 ott 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 set 2010

    LRESSP

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 mag 2010

    • Capitale: GBP 9,653,698.64
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ken Konishi il 26 apr 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 22 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ken Konishi il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Hiroaki Sano il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Simmlaw Services Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2006

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SIMMLAW SERVICES LIMITED
    c/o C/O Simmons & Simmons
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9SS London
    Citypoint
    United Kingdom
    Segretario
    c/o C/O Simmons & Simmons
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9SS London
    Citypoint
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02919427
    79439640001
    KONISHI, Ken
    Lyndhurst Gardens
    N3 1TA London
    1a
    United Kingdom
    Amministratore
    Lyndhurst Gardens
    N3 1TA London
    1a
    United Kingdom
    United KingdomJapaneseCompany Executive135343020001
    SANO, Hiroaki
    Shirokane 1-Chome
    108-0072 Minato-Ku
    25-18-803
    Tokyo
    Japan
    Amministratore
    Shirokane 1-Chome
    108-0072 Minato-Ku
    25-18-803
    Tokyo
    Japan
    JapanJapaneseCompany Executive135334750001
    MATTIUZZO, Mauro
    70 Church Road
    Wimbledon Village
    SW19 5AA London
    Segretario
    70 Church Road
    Wimbledon Village
    SW19 5AA London
    British97758680001
    PULLEN, David John Dowsing
    44 Wimbledon Close
    The Downs
    SW20 8HL London
    Segretario
    44 Wimbledon Close
    The Downs
    SW20 8HL London
    British12663690002
    PULLEN, David John Dowsing
    Bray House
    Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Segretario
    Bray House
    Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    British12663690001
    REDWOOD, Mark Paul
    13 Pinecroft Court
    410 Upper Wickham Lane
    DA16 3ET Welling
    Kent
    Segretario
    13 Pinecroft Court
    410 Upper Wickham Lane
    DA16 3ET Welling
    Kent
    BritishFinance Director77644530001
    AKIYAMA, Toru
    3 West Hill Way
    N20 8QX London
    Amministratore
    3 West Hill Way
    N20 8QX London
    JapaneseFinancial Director87368600002
    ATKIN, Douglas John
    7 Aubert Park
    Highbury
    N5 1TL London
    Amministratore
    7 Aubert Park
    Highbury
    N5 1TL London
    BritishAdvertising Executive15458950001
    CRANMER, Mark
    52 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Amministratore
    52 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    BritishAdvertising Exec37454650001
    DUNCAN, Grant
    75 Tantallian Road
    SW12 London
    Amministratore
    75 Tantallian Road
    SW12 London
    BritishAdvertising Exec50432690001
    ELLSE, Simon Richard
    Acorns
    Steels Lane
    KT22 0RF Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Acorns
    Steels Lane
    KT22 0RF Oxshott
    Surrey
    BritishChartered Accountant34468680001
    GODFREE, David
    105 Oxford Gardens
    W10 6NF London
    Amministratore
    105 Oxford Gardens
    W10 6NF London
    BritishAdvertising Executive35895890001
    HASTINGS, Nicholas
    67 Chesterton Road
    W10 6EP London
    Amministratore
    67 Chesterton Road
    W10 6EP London
    BritishAdvertising Executive35895900001
    HAY, Nicola Peta Roberts
    29 The Vineyard
    TW10 6AQ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    29 The Vineyard
    TW10 6AQ Richmond
    Surrey
    BritishChartered Accountant15445060001
    HEWITT, James Neil Terry
    Amner Road
    SW11 6AA London
    24
    Amministratore
    Amner Road
    SW11 6AA London
    24
    EnglandBritishChartered Accountant140690530001
    JONES, David Bernard Alston
    The Garden Flat
    82 Eaton Place
    SW1X 8AV London
    Amministratore
    The Garden Flat
    82 Eaton Place
    SW1X 8AV London
    BritishChief Executive53608110001
    KONISHI, Ken
    9 Greenfield Drive
    East Finchely
    N2 9AF London
    Amministratore
    9 Greenfield Drive
    East Finchely
    N2 9AF London
    JapaneseChief Financial Officer87637070001
    LANGDON, Richard Benedict
    Little Kimble House
    Little Kimble
    HP17 0UF Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Kimble House
    Little Kimble
    HP17 0UF Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAdvertising Executive148790870001
    MACLEOD, Christopher
    129 Chevening Road
    NW6 6DX London
    Amministratore
    129 Chevening Road
    NW6 6DX London
    EnglandBritishCompany Director19776980003
    PULLEN, David John Dowsing
    44 Wimbledon Close
    The Downs
    SW20 8HL London
    Amministratore
    44 Wimbledon Close
    The Downs
    SW20 8HL London
    BritishSolicitor12663690002
    REYNOLDS, Mark William John
    1 Beaufort Mansions
    SW3 5AG London
    Amministratore
    1 Beaufort Mansions
    SW3 5AG London
    BritishAdvertising Exec64780800001
    RITCHIE, John Vivian
    47 Oakley Gardens
    SW3 5QQ London
    Amministratore
    47 Oakley Gardens
    SW3 5QQ London
    BritishAdvertising Executive12054380001
    SALMON, John Michael
    15 Belsize Lane
    NW3 London
    Amministratore
    15 Belsize Lane
    NW3 London
    BritishAdvertising Executiv35543180001
    STUART, John Raymond Charles
    Kendal Place
    61 Upper Richmond Place
    SW15 2QZ Putney London
    18
    Amministratore
    Kendal Place
    61 Upper Richmond Place
    SW15 2QZ Putney London
    18
    EnglandBritishAdvertising Executive103583840002
    TERASAWA, Ken
    67 Quai Branly
    FOREIGN 75007 Paris
    France
    Amministratore
    67 Quai Branly
    FOREIGN 75007 Paris
    France
    JapaneseManaging Director114378350001
    WILSON, John Hewitt
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Amministratore
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    BritishMedia Buyer15459200001
    YOSHIDA, Hiromi
    1 Kingfisher House
    6 Melbury Road
    W14 8LN London
    Amministratore
    1 Kingfisher House
    6 Melbury Road
    W14 8LN London
    JapaneseAdvertising Executive78931250002

    COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 mar 1993
    Consegnato il 16 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a cross guarantee agreement of even date and/or a facility agreement dated 26TH february 1993
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dentsu Inc
    Transazioni
    • 16 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1996Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1988
    Consegnato il 02 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    110 euston road, london.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 set 1987
    Consegnato il 03 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 110-118 euston road london NW1, title no. Ngl 148020.
    Persone aventi diritto
    • Coults Finance Co
    Transazioni
    • 03 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 nov 1986
    Consegnato il 12 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 feb 1981
    Consegnato il 13 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 21 mar 1974
    Consegnato il 01 apr 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COLLETT, DICKENSON, PEARCE UK ADVERTISING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 apr 2012Data di scioglimento
    27 set 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0