WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED
Panoramica
Nome della società | WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00662286 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e cibo per animali in negozi specializzati (47760) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
THE GARDEN CENTRE GROUP TRADING LIMITED | 17 lug 2009 | 17 lug 2009 |
WYEVALE (LEISURE CENTRES) LIMITED | 09 feb 1987 | 09 feb 1987 |
WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED | 21 set 1983 | 21 set 1983 |
SEVERNVALE GARDEN CENTRE LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
SEVERNVALE NURSERIES LIMITED | 15 giu 1960 | 15 giu 1960 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 16 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 20 mag 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2022 | 14 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 22 feb 2022 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 07 set 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 01 lug 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 14 lug 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 006622860013 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Laura Harradine-Greene come segretario in data 07 mag 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 36 pagine | AA | ||||||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 006622860013 | 11 pagine | MR05 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF England a Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF in data 06 gen 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 06 nov 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 006622860010 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 006622860013, creata il 24 set 2019 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACLACHLAN, Richard John | Amministratore | The Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited | England | British | Director | 255019700001 | ||||
BOURLET, Mary Elizabeth | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 212999430002 | |||||||
HARRADINE-GREENE, Laura | Segretario | Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road TW8 9DF Brentford Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Middlesex England | 242725840001 | |||||||
JENKINSON, Antonia Scarlett | Segretario | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | British | Investment Banker | 72128340003 | |||||
JONES, Anthony David | Segretario | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | Chartered Accountant | 73622510001 | |||||
MURFIN, Stephen | Segretario | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | 8690590001 | ||||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Segretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | Finance Director | 76162020001 | |||||
STEINMEYER, Nils Olin | Segretario | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex United Kingdom | 173113400001 | |||||||
WARD, Elizabeth Ann | Segretario | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | 205448330001 | |||||||
BRADSHAW, Kevin Michael | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex United Kingdom | England | British | Company Director | 124019940001 | ||||
BRIGDEN, Peter | Amministratore | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director Of Retail Operation | 195802400001 | ||||
EVANS, Brian Arnold | Amministratore | The Vern Marden HR1 3EX Hereford Herefordshire | British | Company Director | 8690600001 | |||||
FAVELL, Gary Alan | Amministratore | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | Chief Executive Director | 107699240001 | ||||
HEWITT, Robert John | Amministratore | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15486070002 | ||||
HODKINSON, James Clifford | Amministratore | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | Company Director | 606430001 | ||||
JENKINSON, Antonia Scarlett | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | Investment Banker | 72128340003 | ||||
JONES, Anthony Gerald | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Director | 212265950002 | ||||
KING, Justin Matthew | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 213157990001 | ||||
KOZLOWSKI, Richard Leon | Amministratore | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 124967710001 | ||||
LIVINGSTON, William Andrew | Amministratore | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | Commercial Director | 111439220001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MCLAUGHLAN, Roger | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Ceo | 206428840001 | ||||
MORGAN, Stephen | Amministratore | The Chestnuts Bishops Frome WR6 5BT Worcester Worcestershire | British | Marketing Director | 69021630001 | |||||
MURFIN, Stephen | Amministratore | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Chartered Accountant | 8690590001 | |||||
MURPHY, Stephen Thomas | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex United Kingdom | England | British | Director | 162853840001 | ||||
PIERPOINT, David Julian | Amministratore | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | Director | 138653690001 | ||||
PITCHER, Stephen John | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 138172490001 | ||||
PRICE, Glyn John | Amministratore | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 73470720001 | ||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Amministratore | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | Finance Director | 76162020001 | ||||
ROBERTSON, Lorraine Anne | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | England | British | Director | 138172640001 | ||||
STEINMEYER, Nils Olin | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex United Kingdom | United Kingdom | German | Fiancial Director | 126422100002 | ||||
STEVENSON, Barry John | Amministratore | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | Company Director | 102595670001 | ||||
TAYLOR, Christopher Stuart | Amministratore | Canwood Checkley HR1 4NF Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 9112450001 | ||||
TREHERNE, Roy Edward | Amministratore | Tremora Llanaber LL42 1AJ Barmouth Gwynedd | British | Company Director | 69053700001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyevale Garden Centres Holdings Limited | 06 giu 2016 | Syon Park, London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 24 set 2019 Consegnato il 26 set 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 27 giu 2019 Consegnato il 01 lug 2019 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 20 set 2017 Consegnato il 28 set 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture") and including, amongst others, trademarks numbered UK00003072267 and UK00002455183. For more details please refer to the debenture. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 20 set 2017 Consegnato il 26 set 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Material intellectual property:. Trademark (logo) - registration no.: UK00003072267;. Trademark (name) - registration no.: UK00002455183;. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security accession deed | Creato il 24 apr 2012 Consegnato il 03 mag 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 22 giu 2010 Consegnato il 30 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in and to the reinvestment account any and all monies standing to the credit of the reinvestment account all rights and benefits accruing to or arising in connection with the reinvestment account see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Share mortgage | Creato il 22 dic 2009 Consegnato il 07 gen 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The investments being the shares -one ordinary £1.00 share in peter barratt's garden centres (beverley) limited see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Shares mortgage | Creato il 19 nov 2009 Consegnato il 27 nov 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All investments see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 04 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession to a debenture | Creato il 23 giu 2006 Consegnato il 07 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from a chargor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 16 set 1986 Consegnato il 07 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or charco sixty limited now known as wgc limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 feb 1986 Consegnato il 28 feb 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land adjoining headstone lane in the l/b of harrow being approx. 3.629 acres. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Further guarantee & debenture | Creato il 22 apr 1981 Consegnato il 08 mag 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0