WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED

WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00662286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e cibo per animali in negozi specializzati (47760) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE GARDEN CENTRE GROUP TRADING LIMITED17 lug 200917 lug 2009
    WYEVALE (LEISURE CENTRES) LIMITED09 feb 198709 feb 1987
    WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED21 set 198321 set 1983
    SEVERNVALE GARDEN CENTRE LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    SEVERNVALE NURSERIES LIMITED15 giu 196015 giu 1960

    Quali sono gli ultimi bilanci di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 20 mag 2023

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2022

    14 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 22 feb 2022

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 07 set 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 mag 2021

    16 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 01 lug 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 14 lug 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 mag 2020

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Soddisfazione dell'onere 006622860013 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Laura Harradine-Greene come segretario in data 07 mag 2020

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    36 pagineAA

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 006622860013

    11 pagineMR05

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF England a Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1) Second Floor, Room 2-3, Great West House Great West Road Brentford Middlesex TW8 9DF in data 06 gen 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 06 nov 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account 30/10/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 006622860010 in pieno

    4 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 006622860013, creata il 24 set 2019

    39 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACLACHLAN, Richard John
    The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    Amministratore
    The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    C/O Teneo Financial Advisory Limited
    EnglandBritishDirector255019700001
    BOURLET, Mary Elizabeth
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    212999430002
    HARRADINE-GREENE, Laura
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1)
    Middlesex
    England
    Segretario
    Second Floor, Room 2-3, Great West House
    Great West Road
    TW8 9DF Brentford
    Wyevale Garden Centres, Gw Business Centre (Gw1)
    Middlesex
    England
    242725840001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    BritishInvestment Banker72128340003
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Segretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    British8690590001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    173113400001
    WARD, Elizabeth Ann
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Segretario
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    205448330001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    EVANS, Brian Arnold
    The Vern
    Marden
    HR1 3EX Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Vern
    Marden
    HR1 3EX Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690600001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Amministratore
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive Director107699240001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Amministratore
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector212265950002
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    MORGAN, Stephen
    The Chestnuts
    Bishops Frome
    WR6 5BT Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    The Chestnuts
    Bishops Frome
    WR6 5BT Worcester
    Worcestershire
    BritishMarketing Director69021630001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishChartered Accountant8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector162853840001
    PIERPOINT, David Julian
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    Amministratore
    33 West Street
    RH7 6QP Dormsland
    Rockvale
    Surrey
    EnglandBritishDirector138653690001
    PITCHER, Stephen John
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector138172490001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    ROBERTSON, Lorraine Anne
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector138172640001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomGermanFiancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    TAYLOR, Christopher Stuart
    Canwood
    Checkley
    HR1 4NF Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Canwood
    Checkley
    HR1 4NF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director9112450001
    TREHERNE, Roy Edward
    Tremora
    Llanaber
    LL42 1AJ Barmouth
    Gwynedd
    Amministratore
    Tremora
    Llanaber
    LL42 1AJ Barmouth
    Gwynedd
    BritishCompany Director69053700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wyevale Garden Centres Holdings Limited
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    06 giu 2016
    Syon Park, London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione01972554
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 set 2019
    Consegnato il 26 set 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 gen 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 29 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 giu 2019
    Consegnato il 01 lug 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 28 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture") and including, amongst others, trademarks numbered UK00003072267 and UK00002455183. For more details please refer to the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 28 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 set 2017
    Consegnato il 26 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Material intellectual property:. Trademark (logo) - registration no.: UK00003072267;. Trademark (name) - registration no.: UK00002455183;.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 26 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 15 ott 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 24 apr 2012
    Consegnato il 03 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties ("the Security Agent")
    Transazioni
    • 03 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the reinvestment account any and all monies standing to the credit of the reinvestment account all rights and benefits accruing to or arising in connection with the reinvestment account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share mortgage
    Creato il 22 dic 2009
    Consegnato il 07 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The investments being the shares -one ordinary £1.00 share in peter barratt's garden centres (beverley) limited see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 07 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Shares mortgage
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 27 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All investments see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 27 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 23 giu 2006
    Consegnato il 07 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Finance Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 07 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 set 1986
    Consegnato il 07 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or charco sixty limited now known as wgc limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1986
    Consegnato il 28 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining headstone lane in the l/b of harrow being approx. 3.629 acres.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    Further guarantee & debenture
    Creato il 22 apr 1981
    Consegnato il 08 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1981Registrazione di un'ipoteca

    WYEVALE GARDEN CENTRES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 mag 2020Inizio della liquidazione
    12 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0