DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED

DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00663867
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAVID BROWN VEHICLE TRANSMISSIONS LIMITED22 giu 198822 giu 1988
    DAVID BROWN & SONS (HUDDERSFIELD) LIMITED30 giu 196030 giu 1960

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Kevin Lucius Lilly come amministratore in data 22 dic 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Mark Edward Shanahan come amministratore in data 22 dic 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Balkar Sohal come amministratore in data 22 dic 2011

    3 pagineAP01

    Nomina di Patrick Joseph O'leary come amministratore in data 22 dic 2011

    3 pagineAP01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2011

    Stato del capitale al 01 lug 2011

    • Capitale: GBP 4,500,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Segretario
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Amministratore
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanDirector61807850002
    SHANAHAN, Mark Edward
    City Place
    Beehive King Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    Amministratore
    City Place
    Beehive King Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SOHAL, Balkar
    City Place
    Beehive King Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    Amministratore
    City Place
    Beehive King Road
    RH6 0PA Gatwick
    The Beehive
    West Sussex
    England
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BUSBY, Terence John
    33 Knowles Lane
    Gomersal
    BD19 4LE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    33 Knowles Lane
    Gomersal
    BD19 4LE Cleckheaton
    West Yorkshire
    British100065770001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    British48318550001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    BAILEY, Roger
    3 Beanland Court
    Aireville Avenue
    BD18 3AF Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Beanland Court
    Aireville Avenue
    BD18 3AF Shipley
    West Yorkshire
    BritishManufacturing Director29110660001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishJoint Che1698880001
    BUSBY, Terence John
    33 Knowles Lane
    Gomersal
    BD19 4LE Cleckheaton
    West Yorkshire
    Amministratore
    33 Knowles Lane
    Gomersal
    BD19 4LE Cleckheaton
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director100065770001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Amministratore
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishJoint Che1698890001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director93041580001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    PRIDEAUX, Christopher Clive
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    21a Primrose Lane
    Kirkburton
    HD8 0QY Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector64753680001
    STOPFORD, Stephen Robert Anthony, Major-General
    18 Thornton Avenue
    SW2 4HG London
    Amministratore
    18 Thornton Avenue
    SW2 4HG London
    BritishCompany Director29110650001
    TADMAN, Richard Stratten
    2 Stead Lane
    Kirkheaton
    HD5 0JP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Stead Lane
    Kirkheaton
    HD5 0JP Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director2838000001
    TRAN, Scott
    35 Bartle Gill Drive
    Baildon
    BD17 6UE Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    35 Bartle Gill Drive
    Baildon
    BD17 6UE Bradford
    West Yorkshire
    BritishEngineering59947330001
    VIGOR, James Alfred
    The Old Vicarage
    15 Butt Lane Hepworth
    HD9 1TF Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    15 Butt Lane Hepworth
    HD9 1TF Holmfirth
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director93696550001
    WHITAKER, Richard Brian
    48 Ryefields
    Scholes Holmfirth
    HD7 1XF Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    48 Ryefields
    Scholes Holmfirth
    HD7 1XF Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director70342650001

    DAVID BROWN DEFENCE EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1992
    Consegnato il 07 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref m*89. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 06 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from each obligor to bankers trust company as agent & trustee for itself the arranger and for each bank on any account whatsoever under the terms of the financing docs (all terms as defined in the credit agreement dated 24.1.90)
    Brevi particolari
    Please see doc M86 for details form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 06 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 05 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined in the charge) to first britannia mezzanine capital B.V. as agent and trustee for itself and for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever under the terms of the financing documents (as defined in the loan agreement).
    Brevi particolari
    (For full details see doc M30).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transazioni
    • 05 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 04 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 30 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Incl. All heritable property and assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1985
    Consegnato il 30 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the east side of thornfield road lockwood huddersfield kirklees west yorkshire title no wyk 314068.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 ott 1985
    Consegnato il 30 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings lying to south of swan lane lockwood huddersfield kirklees west yorkshire title no wyk 314067.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 ott 1985
    Consegnato il 28 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all f/h & l/h properties good will & uncalled capital, book & other debts now & from time to time due owing floating charge on undertaking and all property and assets present and future (see M102).
    Persone aventi diritto
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee.
    Transazioni
    • 28 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 ago 1984
    Consegnato il 13 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0