ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00666487 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 006664870011 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 006664870012 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2020 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Angus Alexander Dodd come amministratore in data 07 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 17 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 23 nov 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 12 ott 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Giltvote Limited come persona con controllo significativo il 01 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Angus Alexander Dodd il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Frances Victoria Heazell il 01 dic 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Michael Ben Jenkins il 01 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAZELL, Frances Victoria | Segretario | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875670001 | |||||||
| SAUNDERS, James Michael Edward | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 192568400002 | |||||
| SLAVIN, Philip Simon | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 267205160001 | |||||
| COOK, Anthony | Segretario | Flat 81 Darwin Court 2-24 Gloucester Avenue NW1 7BQ London | British | 8492960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175104170001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Segretario | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 184444990001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | 201606390001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| GREENSLADE, Daniel Mark | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 164108510003 | |||||
| JENKINS, Michael Ben | Amministratore | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | 221017630001 | |||||
| JONES, Christopher Neville | Amministratore | 55 York Mews GU34 1JD Alton Hampshire | England | British | 109266700001 | |||||
| PARKER, Colin Edward | Amministratore | Wyldings Barling Road Barling SS3 0ND Southend On Sea Essex | British | 33472460001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| STRINGER, Reginald | Amministratore | Pipers Landing Green Lane Albury GU5 9EP Guildford | British | 11500100002 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Amministratore | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WILLIAMS, Brian | Amministratore | 14 Shirley Avenue Cheam SM2 7QR Sutton Surrey | British | 9303850001 | ||||||
| WINGATE, Stephan Anthony | Amministratore | 58 Pont Street SW1X 0AE London | United Kingdom | British | 33528820002 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | England | British | 130493170001 | |||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Amministratore | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giltvote Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ESTATES PROPERTY INVESTMENT COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 03 nov 2017 Consegnato il 09 nov 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 03 nov 2016 Consegnato il 15 nov 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 10 nov 2006 Consegnato il 14 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the outstanding £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 of the company and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The capital sum of £5,329,560 and the investments,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 28 apr 2006 Consegnato il 03 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000.00 and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari The capital sum of £3,090,000 and the investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 21 ago 2003 Consegnato il 27 ago 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal of and interest on the £11,500,000 10 per cent first mortgage debenture stock 2011 and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed supplemental thereto (as defined therein) | |
Brevi particolari The freehold land and buildings known as saxley court 121-129 victoria road horley surrey RH6 9XG title number SY716269. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge and release | Creato il 24 mag 2001 Consegnato il 29 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The principal and interest on the £11,500,000 10 per cent. First mortgage debenture stock 2011 (the "stock") of the company and all other moneys intended to be secured by the deed and the trust deed dated 28 april 1986 and also the deeds supplemental thereto of various dates | |
Brevi particolari The capital sum of £10,050,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments exist at the date of the deed). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit agreement | Creato il 16 gen 1989 Consegnato il 31 gen 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee on behalf of itself, the agent, the issuing bank and the banks under the terms of the loan agreement and the security documents. | |
Brevi particolari First fixed charge on all monies at any time standing to the credit of a/c no 20345202 held with barclays bank PLC and any accounts opened pursuant to clause 11 of the agreement (please see doc for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and charge supplemental to a trust deed dated 28.4.86 | Creato il 14 ott 1988 Consegnato il 21 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing the principal of and the interest on £11,500,000 10% first mortgage debenture stock 2011 of the company to alliance assurance company limited supplemental to a trust deed dated 28.4.86 | |
Brevi particolari £1,450,000.00 cash. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of release and charge supplemental to a trust deed dated 28.4.86 | Creato il 02 set 1987 Consegnato il 23 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500 10% first mortgage debenture stock 2011 supplemental to a trust deed dated 28.4.86 | |
Brevi particolari £7,750,000 cash. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 28 apr 1986 Acquisito il 22 dic 1995 Consegnato il 08 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £11,500,000 mortgage debenture stock 2011 and other monies | |
Brevi particolari 1. tower house,merrion way leeds. 2. the pond street complex pond street and flat street sheffield. 3. the ramus tile unit lakeside industrial estate broad ground road redditch hereford & worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 09 giu 1967 Acquisito il 22 dic 1995 Consegnato il 08 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,000,000 10 per cent secured loan stock 1993/98 and other monies | |
Brevi particolari 1. tower house, merrion way, leeds. 2. the pond street complex pond street and flat street sheffield. 3. the ramus tile unit lakeside industrial estate broad ground road redditch hereford & worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| General memo of charge | Creato il 02 ott 1961 Consegnato il 20 ott 1961 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari Stocks shares securities etc (see doc 30). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0