J.F.EDWARDS & SON LIMITED

J.F.EDWARDS & SON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ.F.EDWARDS & SON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00674624
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    FRP ADVISORY LLP
    Pinnacle 5th Floor 67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    GAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    8 pagine4.72

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * 42 Central Markets West Market Building London EC1A 9PS* in data 08 ott 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mar 2013

    Stato del capitale al 25 mar 2013

    • Capitale: GBP 5,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven John Barber il 01 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Paul Bass il 01 gen 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Simon Tidman il 01 gen 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Mark Twogood come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Removal of director 21/09/2011
    RES13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD United Kingdom

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011

    1 pagineAA01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Indirizzo della sede legale modificato da * Tower Bridge House St Katharine's Way London E1W 1DD* in data 25 ago 2011

    2 pagineAD01

    Nomina di Mr Martin Paul Bass come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Steven John Barber come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Stevens come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Stevens come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di J.F.EDWARDS & SON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARBER, Steven John
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    Amministratore
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    United KingdomBritish162564940001
    BASS, Martin Paul
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    Amministratore
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    EnglandBritish161861430001
    BERRY, Derroll William
    Smithy Street
    E1 3HW London
    45 Dagobert Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Smithy Street
    E1 3HW London
    45 Dagobert Street
    United Kingdom
    EnglandBritish158300880001
    TIDMAN, Simon
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    Amministratore
    Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    Pinnacle 5th Floor 67
    United KingdomBritish64514090001
    ALLEN, Gareth Nelson
    21 Ely Gardens
    TN10 4NZ Tonbridge
    Kent
    Segretario
    21 Ely Gardens
    TN10 4NZ Tonbridge
    Kent
    British96693140002
    STEVENS, Mark Alexander
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    British50139790001
    ALLEN, Gareth Nelson
    21 Ely Gardens
    TN10 4NZ Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    21 Ely Gardens
    TN10 4NZ Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritish96693140002
    COOPER JONES, Timothy John, Mr.
    Careby
    PE9 4EA Stamford
    Hatchers Barn
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Careby
    PE9 4EA Stamford
    Hatchers Barn
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109503930001
    DAVIES, Jeffrey Cedric
    Lords Spring Oast
    Bitchet Green
    TN15 0NA Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Lords Spring Oast
    Bitchet Green
    TN15 0NA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish35065540001
    GLASSOCK, Patrick William
    Taffrail Gardens
    South Woodham Ferrers
    CM3 5WH Chelmsford
    4
    Essex
    Amministratore
    Taffrail Gardens
    South Woodham Ferrers
    CM3 5WH Chelmsford
    4
    Essex
    British30682030002
    STEVENS, Mark Alexander
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    32 Leonard Avenue
    Otford
    TN14 5RB Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish50139790001
    TWOGOOD, Mark
    2 Bargate Bargate Lane
    West Row
    IP28 8PS Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    2 Bargate Bargate Lane
    West Row
    IP28 8PS Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritish60816530005

    J.F.EDWARDS & SON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Full form debenture
    Creato il 31 mar 2010
    Consegnato il 10 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 29 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 giu 2001
    Consegnato il 09 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    With full title guarantee charges £12,770 to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor & Commonalty & Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 09 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 giu 2001
    Consegnato il 09 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    With full title guarantee charges £9,265 to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor & Commonalty & Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 09 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 giu 2001
    Consegnato il 09 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee charges £9,545 to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 09 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 giu 2001
    Consegnato il 09 giu 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The company with full title guarantee charges £11,745 to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 09 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 08 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Confidential Invoice Discounting Limited ("Cid")
    Transazioni
    • 08 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Single debenture
    Creato il 19 apr 1993
    Consegnato il 20 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 giu 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 ago 1981
    Consegnato il 20 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank LTD
    Transazioni
    • 20 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 gen 1981
    Consegnato il 28 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all of any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    J.F.EDWARDS & SON LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 ott 2013Inizio della liquidazione
    06 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony John Wright
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Praticante
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Philip Edward Pierce
    Pinnacle 5th Floor, 67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Pinnacle 5th Floor, 67 Albion Street
    LS1 5AA Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0