CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED

CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00676215
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Drayton Hall Church Road
    West Drayton
    UB7 7PS Middlesex
    England
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAPASCO LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    SLAPVALE LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    CAPE ASBESTOS FIBRES LIMITED28 nov 196028 nov 1960

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Rachel Nancye Amey come amministratore in data 08 mar 2013

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 14 mar 2013

    1 pagineAD01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ott 2012

    Stato del capitale al 05 ott 2012

    • Capitale: GBP 130,200
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom in data 04 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 set 2012

    LRESSP

    Nomina di Christopher Francis Judd come segretario in data 23 mag 2012

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jeremy Philip Gorman come segretario in data 23 mag 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Nomina di Jeremy Philip Gorman come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lucy Turner come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 01 dic 2010

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL in data 01 dic 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    16 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dettagli del segretario cambiati per Lucy Finch Turner il 23 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 18 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Anne George il 18 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JUDD, Christopher Francis
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    Segretario
    Millenia Tower
    One Temasek Avenue
    039192 Singapore
    #09-03
    Singapore
    169530870001
    GEORGE, Victoria Anne
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Tax Adviser134024500001
    CRAIGIE, Claire Louise
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Hill Top
    LS29 9RS Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830002
    GORMAN, Jeremy Philip
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    160675560001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British829660002
    RHODES, Jeremy
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    Segretario
    Grevel Lane
    GL55 6HS Chipping Campden
    Kelmscott
    Gloucestershire
    British129206660001
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Segretario
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    TURNER, Lucy Finch
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    British133976740001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Segretario
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    BritishSolicitor99402260002
    AMEY, Rachel Nancye
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    The Square
    Stockley Park
    UB11 1FW Uxbridge
    9
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant133976650005
    BINGHAM, Richard Keith
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    Amministratore
    Church Road
    Brasted
    TN16 1HZ Westerham
    Beechcroft
    Kent
    BritishAccountant131046090001
    CARTWRIGHT, Paul Ian
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    Amministratore
    195 Highbury Quadrant
    N5 2TE London
    BritishChartered Accountant40873830002
    CRAIGIE, Claire Louise
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Marlborough Square
    LS29 8PU Ilkley
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary82905830001
    GILLESPIE, Andrew James
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 White Moss Close
    Ackworth
    WF7 7QT Pontefract
    West Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant89560440001
    JACKSON, Francis Keith John
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Artists House
    Station Road Goring On Thames
    RG8 9HA Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director15469790001
    PITT-PAYNE, Michael George
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    18 Church Way
    Stone
    HP17 8RG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant829660002
    SMITH, Stephen Harry
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    17 Wilhelmina Avenue
    CR5 1NL Coulsdon
    Surrey
    BritishCompany Secretary64449570001
    WHITWORTH, Benjamin Warwick
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    Amministratore
    Raskelf
    YO61 3LW York
    Sam House Farm
    EnglandBritishSolicitor99402260002
    WIDDOWSON, Ian Richard
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    49 Eghams Wood Road
    HP9 1JX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant16941000001
    CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Hall Avenue
    WF1 2UL Wakefield
    Cape House, 3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    131421100001

    CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating security document
    Creato il 20 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined)
    Brevi particolari
    Freehold properties, (I) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for the Creditors
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second supplemental trust deed
    Creato il 28 apr 1987
    Consegnato il 07 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £3,458,818 10% debenture stock 1986/91 of cape industries public limited company and all other moneys due or to become due pursuant to this deed.
    Brevi particolari
    And all patents see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 gen 1985
    Consegnato il 14 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1) f/h & l/h property of the company. 2). all stocks shares bonds and securities. 3) all book & other debts 4). the uncalled capital goodwill and all patents, patent applications trade marks etc. 5) undertaking and all other property assets and rights. (For full details see doc. M. 96).
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    Transazioni
    • 14 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 gen 1985
    Consegnato il 05 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as trustee for itself and other banks named therein. On any account whatsoever.
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed.
    Creato il 01 apr 1968
    Consegnato il 10 apr 1968
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Debenture stock of the cape asbestos company LTD amounting to £2,600,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed 12/9/66.
    Brevi particolari
    First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Assurance Co. LTD
    Transazioni
    • 10 apr 1968Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust deed
    Creato il 12 set 1966
    Consegnato il 21 set 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD
    Brevi particolari
    First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Assurance Co. LTD.
    Transazioni
    • 21 set 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Eq. Charge
    Creato il 26 lug 1966
    Consegnato il 16 ago 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD
    Brevi particolari
    First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Assurance Co. LTD.
    Transazioni
    • 16 ago 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 02 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 mag 2013Data di scioglimento
    14 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0