CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00676215 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Drayton Hall Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex England England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CAPASCO LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
SLAPVALE LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
CAPE ASBESTOS FIBRES LIMITED | 28 nov 1960 | 28 nov 1960 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Nancye Amey come amministratore in data 08 mar 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Restructuring 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB in data 14 mar 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 3 pagine | 4.71 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 9 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1FW United Kingdom in data 04 ott 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Christopher Francis Judd come segretario in data 23 mag 2012 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeremy Philip Gorman come segretario in data 23 mag 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jeremy Philip Gorman come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lucy Turner come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 01 dic 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cape House 3 Red Hall Avenue Paragon Business Village Wakefield West Yorkshire WF1 2UL in data 01 dic 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 16 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Lucy Finch Turner il 23 dic 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rachel Nancye Carr il 18 dic 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Victoria Anne George il 18 dic 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 03 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDD, Christopher Francis | Segretario | Millenia Tower One Temasek Avenue 039192 Singapore #09-03 Singapore | 169530870001 | |||||||
GEORGE, Victoria Anne | Amministratore | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Tax Adviser | 134024500001 | ||||
CRAIGIE, Claire Louise | Segretario | 4 Hill Top LS29 9RS Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830002 | |||||
GORMAN, Jeremy Philip | Segretario | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | 160675560001 | |||||||
PITT-PAYNE, Michael George | Segretario | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | British | 829660002 | ||||||
RHODES, Jeremy | Segretario | Grevel Lane GL55 6HS Chipping Campden Kelmscott Gloucestershire | British | 129206660001 | ||||||
SMITH, Stephen Harry | Segretario | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
TURNER, Lucy Finch | Segretario | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | British | 133976740001 | ||||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Segretario | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | British | Solicitor | 99402260002 | |||||
AMEY, Rachel Nancye | Amministratore | The Square Stockley Park UB11 1FW Uxbridge 9 Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 133976650005 | ||||
BINGHAM, Richard Keith | Amministratore | Church Road Brasted TN16 1HZ Westerham Beechcroft Kent | British | Accountant | 131046090001 | |||||
CARTWRIGHT, Paul Ian | Amministratore | 195 Highbury Quadrant N5 2TE London | British | Chartered Accountant | 40873830002 | |||||
CRAIGIE, Claire Louise | Amministratore | 15 Marlborough Square LS29 8PU Ilkley West Yorkshire | British | Company Secretary | 82905830001 | |||||
GILLESPIE, Andrew James | Amministratore | 5 White Moss Close Ackworth WF7 7QT Pontefract West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 89560440001 | ||||
JACKSON, Francis Keith John | Amministratore | The Artists House Station Road Goring On Thames RG8 9HA Reading Berkshire | England | British | Company Director | 15469790001 | ||||
PITT-PAYNE, Michael George | Amministratore | 18 Church Way Stone HP17 8RG Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 829660002 | ||||
SMITH, Stephen Harry | Amministratore | 17 Wilhelmina Avenue CR5 1NL Coulsdon Surrey | British | Company Secretary | 64449570001 | |||||
WHITWORTH, Benjamin Warwick | Amministratore | Raskelf YO61 3LW York Sam House Farm | England | British | Solicitor | 99402260002 | ||||
WIDDOWSON, Ian Richard | Amministratore | 49 Eghams Wood Road HP9 1JX Beaconsfield Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 16941000001 | |||||
CAPE CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Red Hall Avenue WF1 2UL Wakefield Cape House, 3 West Yorkshire United Kingdom | 131421100001 |
CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Creato il 20 lug 2001 Consegnato il 26 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any creditor (as defined) | |
Brevi particolari Freehold properties, (I) palmers moor and woodlands park,iver lane,iver,bucks;SGL49469;(ii)botleybrickworks,leyhill,chesham,bucks; (iii) cowley bridge works,iver lane,uxbridge UB8 2JQ; agl 60617 and ag 60620 plus various other properties listed;and all real property,as defined, listed in schedule 6 of the security document and by way of first fixed charge over all its book debts,bank accounts,investments and dividends,uncalled capital and goodwill,intellectual property,plant,machinery,insurances and all related proceeds; floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Second supplemental trust deed | Creato il 28 apr 1987 Consegnato il 07 mag 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing £3,458,818 10% debenture stock 1986/91 of cape industries public limited company and all other moneys due or to become due pursuant to this deed. | |
Brevi particolari And all patents see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Single debenture | Creato il 30 gen 1985 Consegnato il 14 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1) f/h & l/h property of the company. 2). all stocks shares bonds and securities. 3) all book & other debts 4). the uncalled capital goodwill and all patents, patent applications trade marks etc. 5) undertaking and all other property assets and rights. (For full details see doc. M. 96). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 29 gen 1985 Consegnato il 05 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as trustee for itself and other banks named therein. On any account whatsoever. | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental trust deed. | Creato il 01 apr 1968 Consegnato il 10 apr 1968 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Debenture stock of the cape asbestos company LTD amounting to £2,600,000 inclusive of £2,000,000 secured by a trust deed 12/9/66. | |
Brevi particolari First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust deed | Creato il 12 set 1966 Consegnato il 21 set 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD | |
Brevi particolari First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock,. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Eq. Charge | Creato il 26 lug 1966 Consegnato il 16 ago 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,000,000 debenture stock of the cape asbestos company LTD | |
Brevi particolari First floating charge on the company's as collateral security for its guarantee for such stock.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CAPE OFFSHORE SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0