QMH (HOTELS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | QMH (HOTELS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00680479 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QMH (HOTELS) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova QMH (HOTELS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di QMH (HOTELS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| QUEENS MOAT HOUSES (HOTELS) LIMITED | 18 gen 2000 | 18 gen 2000 |
| MOAT HOUSES (HOTELS) LIMITED | 24 nov 1999 | 24 nov 1999 |
| QUEENS MOAT HOUSES (HOTELS) LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
Quali sono gli ultimi bilanci di QMH (HOTELS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per QMH (HOTELS) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per QMH (HOTELS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sally Ann Coughlan il 02 ott 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG a 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 29 set 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Erwin Rieck come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Martin Quinn come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Rosenberg come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di W2001 Two Cv come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di W2001 Britannia Llc come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Erwin Joseph Rieck il 12 set 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di W2001 Two Cv come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di W2001 Britannia Llc come amministratore | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Heather Mulahasani come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di QMH (HOTELS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGHLAN, Sally Ann | Segretario | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford 68 Essex England | British | 107832420001 | ||||||
| QUINN, Martin Joseph | Amministratore | 34 Francis Grove Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | 186571310001 | |||||
| BURGESS, Keith John | Segretario | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Segretario | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||
| JONES, Vanessa | Segretario | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Segretario | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||
| WALLER, Ronald John | Segretario | Brindles 118 Hanging Hill Lane CM13 2HN Brentwood Essex | British | 1210620001 | ||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Segretario | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||
| ABSON, Robert | Amministratore | 24 Rothamsted Avenue AL5 2DJ Harpenden Hertfordshire | British | 46707820001 | ||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Amministratore | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||
| BAIRSTOW, John | Amministratore | Frieze Cottage Coxtie Green Road South Weald CM14 5RE Brentwood Essex | British | 537400001 | ||||||
| BELL, Gerald James | Amministratore | Cavewood Rectory Lane Datchworth SG3 6RD Knebworth Hertfordshire | British | 47018930002 | ||||||
| BOULD, Andrew Robin Douglas | Amministratore | 508 Uxbridge Road HA5 4SG Pinner Middlesex | British | 36875610001 | ||||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Amministratore | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||
| COLES, Alan Clifford | Amministratore | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | 101144900002 | |||||
| COLLYER, Brian Charles | Amministratore | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Amministratore | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||
| EDWARDS, Ian Tudor | Amministratore | Froswick High Street Welford On Avon CV37 8EA Stratford Upon Avon | British | 12742160001 | ||||||
| FINKLEMAN, Michael David | Amministratore | Charlewood Manor Crescent, Seer Green HP9 2QX Beaconsfield Buckinghamshire | British | 66057660001 | ||||||
| GILES, Iain Leslie | Amministratore | 24 Conger Lane Toddington LU5 6BT Dunstable Beds | British | 33838510001 | ||||||
| GOIN, Russell Todd | Amministratore | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | 108675490001 | ||||||
| HERSEY, David Michael | Amministratore | Greenways Ridgeway Hutton Mount CM13 2LS Brentwood Essex | British | 17567250001 | ||||||
| INGLETON, Andrew Norman | Amministratore | Easthorpe Green Farm Marks Tey CO6 1HA Colchester Essex | United Kingdom | British | 12742180001 | |||||
| KABALAN, Fadi | Amministratore | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | 133846470001 | |||||
| KRAIS, Ashley Simon | Amministratore | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | 105921220001 | |||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Amministratore | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 4958800007 | |||||
| MAIDEN, George Barry | Amministratore | Fourwinds Long Walk HP8 4AW Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 8832120001 | ||||||
| MARCUS, Martin Alan | Amministratore | 17 Monkhams Drive IG8 0LG Woodford Green Essex | British | 35543430001 | ||||||
| MENARD, Veronique Pascale Dominique | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | 141156250001 | |||||
| METCALFE, Michael Stuart | Amministratore | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 40294180002 | |||||
| MOORE, Richard John | Amministratore | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | 101144680001 | |||||
| MULAHASANI, Heather Louise | Amministratore | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | 136994090001 | |||||
| OGDEN, Kathryn | Amministratore | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | 114248790002 | ||||||
| PORTER, Allan William | Amministratore | 147 Worrin Road CM15 8JR Shenfield Essex | British | 17567090001 | ||||||
| RIECK, Erwin Joseph | Amministratore | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | 108675520002 |
QMH (HOTELS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A composite guarantee and debenture | Creato il 23 feb 2005 Consegnato il 04 mar 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 24 nov 2004 Consegnato il 14 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 giu 2004 Consegnato il 25 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Creato il 08 giu 2004 Consegnato il 11 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 25 mar 2004 Consegnato il 26 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 02 lug 1982 Consegnato il 21 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H the george hotel, high street, colchester, essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 14 mag 1982 Consegnato il 19 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Europa lodge dirham blackwell garage, darlington. Title no du 54662. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Star hotel, hall away gt. Yarmouth norfolk. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The hind hotel sheep street wallory borough.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Europa lodge hotel birmingham land west bomwich title no. St 71304. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 80 grange road darlington title no. Du 53258. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 40 grange road darlington titel no. Du 37129. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 10 east stockwell street, colchester essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 apr 1982 Consegnato il 27 apr 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 196 maldon road colchester, essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 30 lug 1981 Consegnato il 30 lug 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H the stevenage moat house, high street, oal town, stevenage north, hertfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 31 lug 1978 Consegnato il 03 ago 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property known as chase hotel ross-on-wye hereford and worcester.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0