MEDICOR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMEDICOR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00680567
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MEDICOR LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova MEDICOR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O INTERIOR SERVICES GROUP PLC (J CRANNEY)
    Aldgate House
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MEDICOR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEARCE (LEISURE SERVICES) LIMITED01 nov 199601 nov 1996
    PEARCE PARTNERSHIP HOUSING LIMITED17 ott 199117 ott 1991
    GUILD HOMES LIMITED13 gen 196113 gen 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di MEDICOR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MEDICOR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2011

    Stato del capitale al 16 feb 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 15 dic 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da Parklands Hambrook Lane Stoke Gifford Bristol BS34 8QU in data 08 dic 2010

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    3 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    24 pagineMA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    25 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 15 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Jared Stephen Philip Cranney il 15 feb 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Charles Bennett Houlton il 15 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Lawther il 15 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Nicholas Leigh il 15 feb 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2009

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MEDICOR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    British74806700006
    FORREST, Colin Ian
    3 Tangmere Grove
    KT2 5GT Kingston
    Surrey
    Amministratore
    3 Tangmere Grove
    KT2 5GT Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish56892240002
    HOULTON, Jonathan Charles Bennett
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    United KingdomBritish70905760002
    LAWTHER, David
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Interior Services Group Plc
    33 Aldgate High Street
    EC3N 1AG London
    Aldgate House
    United Kingdom
    United KingdomBritish126540420001
    LEIGH, Timothy Nicholas
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    Amministratore
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    United KingdomBritish28351320001
    HERRING, Brian William
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    Segretario
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    British54999000001
    LEIGH, Timothy Nicholas
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    Segretario
    21 Beaconsfield Road
    Knowle
    BS4 2JE Bristol
    British28351320001
    BATES, David Leonard
    Anjo 16 Bleadon Mill
    BS24 0BE Bleadon
    Avon
    Amministratore
    Anjo 16 Bleadon Mill
    BS24 0BE Bleadon
    Avon
    British10031440002
    CLARK, Peter Arnold
    10 Down Road
    Winterbourne Down
    BS17 1BN Bristol
    Avon
    Amministratore
    10 Down Road
    Winterbourne Down
    BS17 1BN Bristol
    Avon
    British10377700001
    CRIPPS, Bernard John
    34 Chock Lane
    Westbury-On-Trym
    BS9 3EX Bristol
    Amministratore
    34 Chock Lane
    Westbury-On-Trym
    BS9 3EX Bristol
    British1926290001
    CURTIS, Roger Mason
    Haere Mai
    Over Hampden
    HP16 9DZ Prestwood Great Missenden
    Bucks
    Amministratore
    Haere Mai
    Over Hampden
    HP16 9DZ Prestwood Great Missenden
    Bucks
    British10363770001
    HARRIS, David John
    22 Orchid Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6HP Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    22 Orchid Meadow
    Pwllmeyric
    NP6 6HP Chepstow
    Gwent
    British62896510001
    HERRING, Brian William
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    Amministratore
    10 The Circus
    BA1 2EW Bath
    Avon
    British54999000001
    RACKSTRAW, John William
    Snowberry House Pelting Road
    Priddy
    BA5 3BA Wells
    Somerset
    Amministratore
    Snowberry House Pelting Road
    Priddy
    BA5 3BA Wells
    Somerset
    EnglandBritish16851180001
    ROSS, Donald
    Cherry Cottage The Follies
    Rectory Lane Cromhall
    GL12 8AN Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    Cherry Cottage The Follies
    Rectory Lane Cromhall
    GL12 8AN Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British10377750002
    SHELTON, David
    Redcroft Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    Redcroft Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish61920220001
    TAYLOR, Andrew Imray
    27 High Street
    Sherston
    SN16 0LH Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    27 High Street
    Sherston
    SN16 0LH Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish142609660001
    TROTTER, Steve
    Kebbles
    Burford Road
    GL7 3ET Lechlade
    Gloucestershire
    Amministratore
    Kebbles
    Burford Road
    GL7 3ET Lechlade
    Gloucestershire
    United KingdomBritish126539650001

    MEDICOR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 14/06/1999
    Creato il 26 mar 2003
    Consegnato il 05 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts for the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the banks name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 31 gen 2003
    Consegnato il 06 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0