GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED

GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00685638
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    • Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Interpath Ltd
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GULLIVER'S TRAVELS SELF DRIVE LIMITED08 mar 196108 mar 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al22 dic 2018
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 gen 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al22 dic 2017
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 dic 2023

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 dic 2022

    27 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 66 Queen Square Bristol BS1 4BE a C/O Interpath Ltd Ground Floor, 25 King Street Bristol BS1 4PB in data 09 mar 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 dic 2021

    24 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:LIQ06 notice of liquidators resignation
    3 pagineLIQ MISC

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 dic 2020

    29 pagineLIQ03

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 12 feb 2020

    3 pagineREC2

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    35 pagineAM10

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    36 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    45 pagineAM10

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    24 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    24 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    66 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    23 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    24 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Swift House Albert Crescent St Philips Bristol BS2 0UD a C/O Kpmg Llp 66 Queen Square Bristol BS1 4BE in data 21 gen 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Nomina di Mr Philippe Jean Gabriel Harding come segretario in data 12 nov 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gabriel Harding come amministratore in data 12 nov 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HARDING, Philippe Jean Gabriel
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    Segretario
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    252647330001
    HARDING, Nicholas Jacques
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritishCompany Director59803800002
    HARDING, Philippe Jean
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritishManaging Director13041400004
    PATEL, Amrat Ravlabhai
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    Amministratore
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    EnglandBritishFinance Director27005280002
    HARDING, Colette
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    Segretario
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    French3150780001
    GORDON, Kieron
    27 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    27 Grove Road
    Coombe Dingle
    BS9 2RJ Bristol
    Avon
    BritishFinance Director107291220001
    HADLEY, Karl Wayne
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    Amministratore
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    WalesBritishOperations & Key Account Direc118250470002
    HARDING, Colette
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    Amministratore
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    EnglandFrenchCompany Director3150780001
    HARDING, Gabriel
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    Amministratore
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    EnglandBritishCompany Director3150790001
    IRELAND, Nevil William
    15 Perrins Field
    WR8 0ER Upton Upon Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    15 Perrins Field
    WR8 0ER Upton Upon Severn
    Worcestershire
    EnglandBritishRental Director109542910001
    JEREMIAH, Neil John
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    Amministratore
    Swift House
    Albert Crescent St Philips
    BS2 0UD Bristol
    WalesBritishRental Director83054370002
    TAYLOR, Richard George
    Meads Droveway
    Creech Heathfield
    TA3 5EX Taunton
    Sunnymead House
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Meads Droveway
    Creech Heathfield
    TA3 5EX Taunton
    Sunnymead House
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director171851130001
    WHITE, Stephen Paul
    15 Heol Ynys Ddu
    Castle View
    CF83 1SD Caerphilly
    Amministratore
    15 Heol Ynys Ddu
    Castle View
    CF83 1SD Caerphilly
    WalesBritishFleet Director108044990002

    Chi sono le persone con controllo significativo di GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Philippe Jean Gabriel Harding
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    06 apr 2016
    Ground Floor, 25 King Street
    BS1 4PB Bristol
    C/O Interpath Ltd
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 set 2018
    Consegnato il 26 set 2018
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as speed house, green lane, hounslow, TW4 6BY registered at hm land registry with title numbers AGL111403 and AGL111404, for more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 26 set 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 ago 2017
    Consegnato il 31 ago 2017
    Parzialmente soddisfatta
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 31 ago 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 ott 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 13 nov 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 27 mar 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 10 mag 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 23 mag 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 15 nov 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 dic 2016
    Consegnato il 22 dic 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Subjects to the south of hagmill road coatbridge t/nos LAN152981 and LAN152978.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 nov 2016
    Consegnato il 07 nov 2016
    Parzialmente soddisfatta
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 07 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 mar 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 15 giu 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 13 lug 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 08 ago 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 25 ago 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 12 set 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 19 set 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 19 ott 2017Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 27 mar 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 23 mag 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 15 nov 2018Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 ago 2015
    Consegnato il 09 set 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Land on the west side of langley road salford t/no GM515706.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 09 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 227 feb 2019Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 225 feb 2020Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    A registered charge
    Creato il 12 ago 2015
    Consegnato il 20 ago 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Scania Finance Great Britain Limited
    Transazioni
    • 20 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 mag 2015
    Consegnato il 06 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Deed of assignment.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 06 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 24 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 apr 2013
    Consegnato il 27 apr 2013
    In corso
    Breve descrizione
    The property known as speed house, green lane, hounslow, middlesex t/no AGL111403 and AGL111404. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Master deed of assignment
    Creato il 13 ago 2012
    Consegnato il 31 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The full benefit of the sub-lease agreements including the right to receive all monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Lease N.V
    Transazioni
    • 31 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Schedule a to master charge dated 30TH april 2010
    Creato il 04 apr 2012
    Consegnato il 05 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mercedes benz actros 2546, chassis no: WDB9342332L6327806.. Mercedes benz actros 2546, chassis no: WDB9342332L6331688.. Mercedes benz actros 2546, chassis no: WDB9342332L632288. (For further details of equipment charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Leasing (UK) LTD
    Transazioni
    • 05 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over sub-hire agreements
    Creato il 12 lug 2011
    Consegnato il 14 lug 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right in the sub-hire agreements, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 14 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Assignment
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 23 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit present and future of the company in the lease including all rights to receive payments of whatsoever nature thereunder and including without limitation all rights to serve notices and/or make demands thereunder and all rights of action in respect of a breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Jcb Finance Limited
    Transazioni
    • 23 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Master charge
    Creato il 30 apr 2010
    Consegnato il 04 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    New volvo fm 420 6X2 rigid including globetrotter - comfort trim cab reg no WX10 eft & vin no YV2JG10C3AB556363. New volvo fm 420 6X2 rigid including globetrotter - comfort trim cab reg no WX10 efu & vin no YV2JG10C8AB556164. New volvo fm 420 6X2 rigid including globetrotter - comfort trim cab reg no WX10 efr & vin no YV2JG10C4AB556355. All the right, title and interest of the company in respect of the charged quipment, all proceeds of sale or other disposition of the charged equipment and all insurance monies receivable in respect of damage to or the destruction or loss of any of the charged equipment. For further details of equipment charged please refer to the form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Leasing UK LTD
    Transazioni
    • 04 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ago 2009
    Consegnato il 17 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the south west side of sadler road walsall.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 lug 2009
    Consegnato il 25 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subcontracts relating to the goods, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Commercial Finance LTD
    Transazioni
    • 25 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Master security assignment
    Creato il 29 giu 2009
    Consegnato il 18 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any charge property assigned to the owner by the hirer see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Master security assignment
    Creato il 12 giu 2009
    Consegnato il 20 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Daf falf 45 180 box van CN07FEM, daf falf 45.150 day cab + tip loader CN56HCK, man tgx 26.440 bls traction + fidge WX08MPE for further equipment please see form 395 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Asset Finance LTD
    Transazioni
    • 20 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Master security assignment
    Creato il 22 apr 2009
    Consegnato il 29 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Goods charged relating to agreement number AG69000160 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Asset Finance LTD
    Transazioni
    • 29 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment and charge of sub-leasing agreements
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company in sub leases in respect of good comprised in hp leasing or hire agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2008
    Consegnato il 18 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subcontracts entered into any time by the chargor with customer(s) of the chargor relating to the vehicles or other goods now or hereafter owned by man financial services PLC and comprised in the principal contracts; see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Man Financial Services PLC
    Transazioni
    • 18 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplementary schedule
    Creato il 22 feb 2008
    Consegnato il 27 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in the sub-hire agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 27 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2007
    Consegnato il 13 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a swift house land to the south side of aberdeen street and on the west side of albert crescent st phillips bristol t/no BL15115.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2007
    Consegnato il 13 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a land on the north east side of brindley road cardiff t/no WA634094.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2007
    Consegnato il 13 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a harvey house brindley road cardiff t/no WA101073.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Asset sub-hire agreement
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 19 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in sub-hire agreements and related contracts at any time entered into in respect of the goods and in any other contracts at any time entered in to in respect of such goods all the companys rights title and interest in the sub-hire agreements from time to time briefly described in the supplementary schedules executed pursuant to the deed and all related contracts.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland Business Finance Limited
    Transazioni
    • 19 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    GULLIVER'S TRUCK HIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 dic 2018Inizio dell'amministrazione
    04 dic 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Pike
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Praticante
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Mark Jeremy Orton
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Praticante
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven John Williams
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    Ricevitore/gestore
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    David Robert Acland
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Ricevitore/gestore
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    3
    DataTipo
    04 dic 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Pike
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Praticante
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Mark Jeremy Orton
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Praticante
    66 Queen Square
    BS1 4BE Bristol
    Avon
    Christopher Robert Pole
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0