HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED

HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARPERS WINES & SPIRITS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00687138
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    • (2213) /

    Dove si trova HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    288 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHBURY-HARPERS LIMITED07 giu 200207 giu 2002
    HARPER TRADE JOURNALS LIMITED21 mar 196121 mar 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Cessazione della carica di Robin Dummett come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di William Twyman Iii Comfort come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 ago 2009

    LRESSP

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    16 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    16 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIRD, Fiona Mary
    Grantley Close
    GU4 8DL Shalford
    2
    Surrey
    Segretario
    Grantley Close
    GU4 8DL Shalford
    2
    Surrey
    Irish136809690001
    COMFORT, William Twyman Iii
    21 Manresa Road
    Chelsea
    SW3 6LZ London
    Flat 2
    Amministratore
    21 Manresa Road
    Chelsea
    SW3 6LZ London
    Flat 2
    UkUnited States90962970002
    ANJARWALLA, Hafeez Kaiyumali
    215 Wandsworth Bridge Road
    Fulham
    SW6 2TT London
    Segretario
    215 Wandsworth Bridge Road
    Fulham
    SW6 2TT London
    British82450700001
    CARTER, Neal
    58 Almond Grove
    Hempstead
    ME7 3SE Gillingham
    Kent
    Segretario
    58 Almond Grove
    Hempstead
    ME7 3SE Gillingham
    Kent
    British82064550001
    CHALMERS, Alan David
    39 Drayton Gardens
    W13 0LG London
    Segretario
    39 Drayton Gardens
    W13 0LG London
    British50887640001
    COSTELLO, Kieran James
    79 Priory Road
    Crouch End
    N8 8LR London
    Segretario
    79 Priory Road
    Crouch End
    N8 8LR London
    British31958660002
    DAVIES, Owen Wyn
    SW20
    Segretario
    SW20
    British45241980002
    LAW, Bruce Marcus Alexander
    106 Ashley Road
    KT12 1HP Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    106 Ashley Road
    KT12 1HP Walton On Thames
    Surrey
    British31491310001
    NICOLL, Derek
    118 Fleet Road
    GU14 9RG Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    118 Fleet Road
    GU14 9RG Farnborough
    Hampshire
    British56177890001
    HAL MANAGEMENT LIMITED
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    Segretario
    Hanover House
    14 Hanover Square
    W1S 1HP London
    2851030001
    ATKIN, Timothy John
    40 Clive Road
    SW19 2JB London
    Amministratore
    40 Clive Road
    SW19 2JB London
    British73590020001
    BARKER, Pamela Jeanne
    12 Turnstone House
    Star Place
    E1W 1AE London
    Amministratore
    12 Turnstone House
    Star Place
    E1W 1AE London
    British26089600003
    BARKLEM, Nigel Jeremy
    Lambridge Lane
    RG9 4NR Henley-On-Thames
    Badgemore End
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lambridge Lane
    RG9 4NR Henley-On-Thames
    Badgemore End
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish131559650001
    BARNARD, Lisa Jane
    78 Whitehall Park
    N19 3TN London
    Amministratore
    78 Whitehall Park
    N19 3TN London
    EnglandBritish73297090001
    BLOXHAM, John
    34 Mannock Drive
    IG10 2JB Loughton
    Essex
    Amministratore
    34 Mannock Drive
    IG10 2JB Loughton
    Essex
    British8630660002
    CHALMERS, Alan David
    39 Drayton Gardens
    W13 0LG London
    Amministratore
    39 Drayton Gardens
    W13 0LG London
    British50887640001
    DAVIES, Owen Wyn
    SW20
    Amministratore
    SW20
    United KingdomBritish45241980002
    DUMMETT, Robin Piers
    St Albans Gardens
    TW11 8AE Teddington
    19
    Middlesex
    Amministratore
    St Albans Gardens
    TW11 8AE Teddington
    19
    Middlesex
    United KingdomBritish124151850003
    FLETCHER, Ian David
    Herbert House
    High Laver
    CM5 0DZ Ongar
    Essex
    Amministratore
    Herbert House
    High Laver
    CM5 0DZ Ongar
    Essex
    United KingdomBritish41834060002
    GILCHRIST, Andrew Iain
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    Amministratore
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    EnglandBritish89940590001
    HAWSER, Anthony
    22 Wilton Street
    SW1X 7AX London
    Amministratore
    22 Wilton Street
    SW1X 7AX London
    British8207480001
    HEY, Charlotte Louise
    109 Victoria Road
    NW6 6TD London
    Amministratore
    109 Victoria Road
    NW6 6TD London
    United KingdomBritish73589970001
    ISAAC, Jeremy David Gower
    1 Chaldon Road
    SW6 7NH London
    Amministratore
    1 Chaldon Road
    SW6 7NH London
    British62088640004
    JUDE, Nicholas Frederick
    Apartment 124 Baltic Quay
    1 Sweden Gate
    SE16 7TG Surrey Quays
    London
    Amministratore
    Apartment 124 Baltic Quay
    1 Sweden Gate
    SE16 7TG Surrey Quays
    London
    British87555310001
    RANKIN, Stephanie Mabel Alexandra
    15 Oliver Avenue
    SE25 6TY London
    Amministratore
    15 Oliver Avenue
    SE25 6TY London
    British26467980001
    SALTER, Anthony Richard
    38 Bennett Park
    Blackheath
    SE3 9RB London
    Amministratore
    38 Bennett Park
    Blackheath
    SE3 9RB London
    United KingdomBritish104471190001
    SATCHWILL, Peter Christopher
    7 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    7 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    Berkshire
    EnglandBritish82587650001
    SIMPSON, Mark Andrew Goodman
    Littleton House
    Blandford St. Mary
    DT11 9NA Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Littleton House
    Blandford St. Mary
    DT11 9NA Blandford Forum
    Dorset
    British56280120002
    STRAKER, Patrick Vincent
    Kier Lodge Heath House Road
    GU22 0RD Woking
    Surrey
    Amministratore
    Kier Lodge Heath House Road
    GU22 0RD Woking
    Surrey
    British8172810001
    STRAKER, Stephen Vincent
    Cromden Lodge
    Manor Road
    RH2 Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Cromden Lodge
    Manor Road
    RH2 Reigate
    Surrey
    British8593930001
    STRAKER, Timothy John
    Little Danley
    Lynchmere
    GU27 Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Little Danley
    Lynchmere
    GU27 Haslemere
    Surrey
    British8596110001
    TAYLOR, Marijke Janneke
    54 Telford Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4XF London
    Amministratore
    54 Telford Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4XF London
    Dutch35951300001
    THACKRAY, Neil
    Herrings
    Twineham Lane
    RH17 5NP Twineham
    West Sussex
    Amministratore
    Herrings
    Twineham Lane
    RH17 5NP Twineham
    West Sussex
    United KingdomBritish77633700002
    TORINO, Peter Antony
    25 Leith Mansions
    Grantully Road Maida Vale
    W9 1LQ London
    Amministratore
    25 Leith Mansions
    Grantully Road Maida Vale
    W9 1LQ London
    EnglandBritish30945050002
    WINTLE, Donald William
    Thicket Cottage
    Littlewick Green
    SL6 Maidenhead
    Berks
    Amministratore
    Thicket Cottage
    Littlewick Green
    SL6 Maidenhead
    Berks
    British8630670001

    HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 04 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture between the company (the chargor) and barclays bank PLC (the agent)
    Creato il 22 set 2000
    Consegnato il 27 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of any obligor (as defined) to each transaction party (as defined) under each transaction document (as defined) to which the chargor is a party
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge supplemental to a guarantee and debenture dated 8TH july 1996 issued by the company
    Creato il 23 set 1998
    Consegnato il 05 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid guarantee and debenture
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in or aising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 27TH february 1998 for full details please refer to form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 feb 1998
    Consegnato il 02 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a factoring agreement (as therein defined) or otherwise
    Brevi particolari
    Any debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement which fails to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason and all indebtedness owing or due to the company on any account with the related rights thereto and a floating charge all monies received in respect of the other debts as shall stand released from the fixed charge above.
    Persone aventi diritto
    • Gle Invoice Finance LTD
    Transazioni
    • 02 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or harpers press limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of the fourth floor in the north block of harling house, 47/51 great suffolk street, london borough of southwark as comprised in a lease dated 12-1-1996.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 lug 1996
    Consegnato il 17 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or harpers press limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 apr 1992
    Consegnato il 02 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 14 feb 1990
    Consegnato il 21 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 mag 1984
    Consegnato il 22 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts present & future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    HARPERS WINES & SPIRITS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 ott 2010Data di scioglimento
    11 ago 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Michael Sutcliffe
    Sutcliffe & Co
    288 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Surrey
    Praticante
    Sutcliffe & Co
    288 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Surrey

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0