EDMOND HOMES LIMITED

EDMOND HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEDMOND HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00687769
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EDMOND HOMES LIMITED?

    • (4521) /

    Dove si trova EDMOND HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EDMOND HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EDMOND (BUILDERS) LIMITED24 mar 196124 mar 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di EDMOND HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per EDMOND HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 mar 2010

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 dic 2009

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 23 dic 2008

    LRESEX

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    14 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2001

    11 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di EDMOND HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAKHANI, Amit
    The Gate House
    Barkham Road
    RG41 4TG Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    The Gate House
    Barkham Road
    RG41 4TG Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant52725580003
    BRUNSKILL, Nigel Harborough
    Rutland House
    Main Street
    YO62 5JE Harome
    Yorkshire
    Amministratore
    Rutland House
    Main Street
    YO62 5JE Harome
    Yorkshire
    EnglandBritishLand Buyer102857260001
    LAKHANI, Amit
    The Gate House
    Barkham Road
    RG41 4TG Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Gate House
    Barkham Road
    RG41 4TG Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant52725580003
    REYNOLDS, Richard Frederick
    115 Blanchland Circle
    Monkston
    MK10 9DR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    115 Blanchland Circle
    Monkston
    MK10 9DR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritishConsruction Director79590870001
    BENSON, Eric Howard
    38 Thornwick Avenue
    Willerby
    HU10 6LP Hull
    North Humberside
    Segretario
    38 Thornwick Avenue
    Willerby
    HU10 6LP Hull
    North Humberside
    British4048000001
    FOLEY, Kevin Paul
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Segretario
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    British150134410001
    FRISBY, Ian Martyn
    6 Rennishaw Way
    Links View
    NN2 7NE Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    6 Rennishaw Way
    Links View
    NN2 7NE Northampton
    Northamptonshire
    British18845860002
    HOOKE, Richard David
    6 Fisher Close
    Willerby
    HU10 6HA Hull
    Segretario
    6 Fisher Close
    Willerby
    HU10 6HA Hull
    British10958750001
    ARMITAGE, John
    Middle Meadow 19 Main Street
    Kirkburn
    YO25 9DU Driffield
    Amministratore
    Middle Meadow 19 Main Street
    Kirkburn
    YO25 9DU Driffield
    EnglishCompany Director11048640001
    CHALCRAFT, Richard Leslie
    Leggats 25 High Street
    Flore
    NN7 4LL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Leggats 25 High Street
    Flore
    NN7 4LL Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector10958790001
    DENNETT, David Ian
    Broxa Swanland Garth
    N Ferriby
    HU14 3LL Hull
    N Humberside
    Amministratore
    Broxa Swanland Garth
    N Ferriby
    HU14 3LL Hull
    N Humberside
    BritishCompany Director11048650001
    FOLEY, Kevin Paul
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    18 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    United KingdomBritishFinancial Director150134410001
    MAW, Graham Hamilton
    34 Tower Hill Drive
    HU13 0SL Hessle
    North Humberside
    Amministratore
    34 Tower Hill Drive
    HU13 0SL Hessle
    North Humberside
    BritishCompany Director62194180001
    NAISH, Andrew William
    3 The Hawk House The Falcons
    Falcon Road Clapham Junction
    SW11 2NN London
    Amministratore
    3 The Hawk House The Falcons
    Falcon Road Clapham Junction
    SW11 2NN London
    BritishDirector35575430001
    ROWE, Patricia
    Redgarth
    6 Newgate Street
    HU16 4DT Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    Redgarth
    6 Newgate Street
    HU16 4DT Cottingham
    North Humberside
    BritishSales Director61475080001
    SPENCER, Jonathan Peter
    6 Varsity Row
    SW14 8SA London
    Amministratore
    6 Varsity Row
    SW14 8SA London
    BritishManaging Director38821550001
    TEAR, Alan Henry
    67 Breakleys Road
    Desborough
    NN14 2PT Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    67 Breakleys Road
    Desborough
    NN14 2PT Kettering
    Northamptonshire
    BritishConstruction Director31217570001

    EDMOND HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 06 ott 1995
    Consegnato il 23 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property situate at ferndale avenue willerby hull and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 ott 1995
    Consegnato il 20 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/as land on the south west side of the balk (also k/as "land comprising phase ii) pocklington humberside.t/no.HS242725 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 04 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as two parcels of land on the south and south east sides of kings court road thorne south yorkshire (also known as "kings thorne humberside") and the proceeds of sale thereof; t/no.syk 340760. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 04 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as land on the north side of selby rd,howden,humberside and the proceeds of sale thereof; t/no hs 234273. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 set 1995
    Consegnato il 02 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 set 1995
    Consegnato il 09 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land off scawby road (also k/a part of yarborough mill brigg) brigg south yorkshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 13 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Grosvenor southgate hornsea humberside t/n HS105300.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 13 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    9 the paddocks broadacres carlton north yorkshire t/n NYK61626.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1995
    Consegnato il 13 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 hawthorne garth kellington north yorkshire t/n NYK85695.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1995
    Consegnato il 03 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Phase ii at the balk pocklington humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 1994
    Consegnato il 28 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £515,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at selby road howden north humberside.
    Persone aventi diritto
    • Edward Winter
    • Holly Tree Cottage
    Transazioni
    • 28 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 1994
    Consegnato il 25 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at selby road howden north humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1994
    Consegnato il 11 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at kings court thorne doncaster t/n SYK234787.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1993
    Consegnato il 20 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at manor farm chapel haddlesey selby north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 gen 1993
    Consegnato il 20 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at tweendykes road, sutton, hull, humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 gen 1989
    Consegnato il 25 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land containing 1.87 acres or thereabouts on the east side of shannon road, hull, humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 30 apr 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 lug 1987
    Consegnato il 17 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land off craven street kingston-upon-hull humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 feb 1987
    Consegnato il 11 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 dic 1986
    Consegnato il 23 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land to the n/w of james reckitt ave, kingston-upon-hull. T.N.:- 112506.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 giu 1986
    Consegnato il 27 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land to the north west of james reckitt avenue, kingston upon hull, humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 1984
    Consegnato il 20 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of dam road, barton on humber humberside. Tn: hs 63477.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 ago 1984
    Consegnato il 07 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land situate at the north end of aston hall drive at north ferriby, north humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 ago 1984
    Consegnato il 04 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H plots 9/14 (inclusive) and 16/19 (inclusive) skirlaw close, pinfold street, howden, humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 1983
    Consegnato il 01 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 204 stafford st burton on trent staffordshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1983
    Consegnato il 13 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at ferndale ave, willerby, hull,humberside.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EDMOND HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 dic 2008Inizio della liquidazione
    26 giu 2010Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Anthony Cliff Spicer
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Praticante
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0