BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED
Panoramica
Nome della società | BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00688041 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
Dove si trova BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Blake House 3 Frayswater Place Cowley UB8 2AD Uxbridge Middlesex United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GRANITE CONSTRUCTION LIMITED | 08 mar 1988 | 08 mar 1988 |
GRANITE CONSTRUCTION (DERBY) LIMITED | 27 mar 1961 | 27 mar 1961 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione di Galliford Try Building 2014 Limited come persona con controllo significativo il 27 lug 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Galliford Try Construction (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 23 dic 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Galliford Try Construction (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Notifica di Galliford Try Corporate Holdings Limited come persona con controllo significativo il 27 lug 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Galliford Try Secretariat Services Limited il 18 gen 2021 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cowley Business Park Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AL a Blake House 3 Frayswater Place Cowley Uxbridge Middlesex UB8 2AD in data 18 gen 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Neil David Cocker come amministratore in data 30 giu 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Cooper come amministratore in data 30 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Martin Cooper il 15 mag 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Thomas Jubb il 22 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALLIFORD TRY SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 3 Frayswater Place Cowley UB8 2AD Uxbridge Blake House Middlesex United Kingdom |
| 167168750001 | ||||||||||
COCKER, Neil David | Amministratore | Rossett Close Northwich CW9 8WP Cheshire 5 United Kingdom | England | British | Company Director | 260158230001 | ||||||||
JUBB, Ian Thomas | Amministratore | 3 Frayswater Place Cowley UB8 2AD Uxbridge Blake House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | Senior Management | 162269970002 | ||||||||
COX, John Andrew | Segretario | 9 Premier Avenue DE6 1LH Ashbourne Derbyshire | British | 30901630004 | ||||||||||
DONALDSON, Euan James | Segretario | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | Director | 41273760002 | |||||||||
MACKINNON, Iain Lachlan | Segretario | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||||||
SMYTH, Pamela June | Segretario | 6060 Knights Court, Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WY Birmingham C/O Miller Construction (Uk) Limited West Midland | British | 65057960002 | ||||||||||
WILSON, Mark William | Segretario | 18 Silverdale Close Ecclesall S11 9JN Sheffield South Yorkshire | British | 78419380001 | ||||||||||
COOPER, Martin | Amministratore | Cowley UB8 2AL Uxbridge Cowley Business Park Middlesex England | Scotland | British | Chartered Accountant | 156200280002 | ||||||||
COX, John Andrew | Amministratore | 9 Premier Avenue DE6 1LH Ashbourne Derbyshire | British | Chartered Accountant | 30901630004 | |||||||||
ENDSOR, Christopher John | Amministratore | Maple Croft Dalbury Lees DE6 5BE Ashbourne Derbyshire England | United Kingdom | British | Managing Director | 86411120001 | ||||||||
FINNEGAN, Thomas Gerard | Amministratore | 6 Swallow Close Mickleover DE3 5XD Derby | British | Quantity Surveyor | 6043480003 | |||||||||
GADSBY, Peter James | Amministratore | Burley Grange Burley Lane Quarndon DE22 5JR Derby Derbyshire | England | British | Chairman | 93167510001 | ||||||||
GIBSON, Neil Calum | Amministratore | 139 Overlane DE56 0HN Belper Derbyshire | British | Estimating Director | 33685320001 | |||||||||
GOODWIN, Roger Charles | Amministratore | 50 Green Lane Ockbrook DE72 3SE Derby | British | Development Director - Design | 33685310001 | |||||||||
HODSDEN, Richard David | Amministratore | 6060 Knights Court, Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WY Birmingham C/O Miller Construction (Uk) Limited West Midland | England | British | Finance Director | 183337930001 | ||||||||
LITTING, Kevin George Wedgwood | Amministratore | Cedar House 15 Hollies Road Allestree DE22 2HX Derby | United Kingdom | British | Financial Director | 41497590002 | ||||||||
MCBRIDE, Garry | Amministratore | 12 Cumberhills Road Duffield DE56 4HA Derby Derbyshire | British | Company Director | 53509590001 | |||||||||
MILLER, Keith Manson | Amministratore | 6060 Knights Court, Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WY Birmingham C/O Miller Construction (Uk) Limited West Midland | Scotland | British | Company Director | 546650002 | ||||||||
RICHARDS, John Steel | Amministratore | 6060 Knights Court, Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7WY Birmingham C/O Miller Construction (Uk) Limited West Midland | United Kingdom | British | Financial Director | 1318380002 | ||||||||
SMALLEY, William Anthony | Amministratore | Furnace Pond Farm Dale Road DE7 4PF Dale Abbey Derbyshire | British | Contracts Director | 84234000001 | |||||||||
TURNER, Charles Robert | Amministratore | 45 Charlecote Drive NG8 2SD Nottingham Nottinghamshire | British | Marketing Director | 21893200001 | |||||||||
WHEATCROFT, Mitchell | Amministratore | 17 Bakers Hill Heage DE56 2BL Belper Derbyshire | British | Estimator | 6043510001 | |||||||||
WILSON, Mark William | Amministratore | 18 Silverdale Close Ecclesall S11 9JN Sheffield South Yorkshire | British | Finance | 78419380001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galliford Try Corporate Holdings Limited | 27 lug 2021 | 2 Lochside View EH12 1LB Edinburgh PO BOX 17452 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Galliford Try Building 2014 Limited | 06 apr 2016 | Lochside View 17452 EH12 1LB Edinburgh 2 Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BIRCH CONSTRUCTION DIVISION LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 19 dic 1996 Consegnato il 30 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 16 mar 1989 Consegnato il 23 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 gen 1988 Consegnato il 27 gen 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 08 ott 1982 Consegnato il 13 ott 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0