GLOBAL MP LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBAL MP LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00693401
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLOBAL MP LTD.?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
    • servizi di prestampa e pre-media (18130) / Industrie manifatturiere
    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova GLOBAL MP LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLOBAL MP LTD.?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ST IVES DIRECT BRADFORD LIMITED01 mar 200401 mar 2004
    HUNTERS ARMLEY LIMITED08 nov 199108 nov 1991
    HUNTERS ARMLEY HOLDINGS LIMITED 23 mag 196123 mag 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBAL MP LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 lug 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBAL MP LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 nov 2016

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 24 mag 2016

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 nov 2015

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 giu 2015

    19 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 dic 2014

    19 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    52 pagine2.17B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    52 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da Battye Street Laisterdyke Bradford West Yorkshire BD4 8AG a 3 Hardman Street Manchester M3 3HF in data 25 lug 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 006934010011 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 006934010014

    33 pagineMR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed st ives direct bradford LIMITED\certificate issued on 27/11/13
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name27 nov 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 02 nov 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Iscrizione dell'ipoteca 006934010013

    24 pagineMR01

    Nomina di Mr Kevin Martin Dunstall come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * One Tudor Street London EC4Y 0AH United Kingdom* in data 10 ott 2013

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di GLOBAL MP LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNSTALL, Kevin Martin
    Battye Street
    BD4 8AG Bradford
    St Ives House
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Battye Street
    BD4 8AG Bradford
    St Ives House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish182863570001
    FLETCHER, Andrew Richard
    Lowfield House 25 Dearneside Road
    Denby Dale
    HD8 8TL Huddersfield
    Segretario
    Lowfield House 25 Dearneside Road
    Denby Dale
    HD8 8TL Huddersfield
    British1524430001
    HARRIS, Philip Charles
    33 Seething Wells Lane
    KT6 5NA Surbiton
    Surrey
    Segretario
    33 Seething Wells Lane
    KT6 5NA Surbiton
    Surrey
    British1770540003
    ADLINGTON, Alan
    16 Stapleton Close
    SL7 1TZ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Stapleton Close
    SL7 1TZ Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish46295030001
    ARMITAGE, Matthew Robert
    Woodcroft
    The Drive Wonersh
    GU5 0QW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Woodcroft
    The Drive Wonersh
    GU5 0QW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish90549730002
    BIRD, David Robertson
    1 The Garth
    Collingham
    LS22 5JT Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 The Garth
    Collingham
    LS22 5JT Wetherby
    West Yorkshire
    British2974630001
    BLACKA, Rodney
    Meadow Bank
    Hill House Lane, Oxenhope
    BD22 9JH Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Meadow Bank
    Hill House Lane, Oxenhope
    BD22 9JH Keighley
    West Yorkshire
    British46295010002
    BUTLER, Angela Mary
    Lincombe Drive
    TQ1 2LP Torquay
    Amber House
    Devon
    Amministratore
    Lincombe Drive
    TQ1 2LP Torquay
    Amber House
    Devon
    EnglandBritish152016650001
    CRAINE, Robert Paul
    Court Cottage Lower Farm
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    Court Cottage Lower Farm
    Madehurst
    BN18 0NU Arundel
    West Sussex
    British32002370002
    DOWNEY, Stephen David
    Flawith
    Alne
    YO61 1SF York
    Chandlers Cottage
    Amministratore
    Flawith
    Alne
    YO61 1SF York
    Chandlers Cottage
    EnglandBritish152018290001
    EDWARDS, Brian Charles
    Sequoia
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Sequoia
    Grassy Lane
    TN13 1PL Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish16989990002
    FLETCHER, Andrew Richard
    Lowfield House 25 Dearneside Road
    Denby Dale
    HD8 8TL Huddersfield
    Amministratore
    Lowfield House 25 Dearneside Road
    Denby Dale
    HD8 8TL Huddersfield
    EnglandBritish1524430001
    FRY, Robin John
    47 Ellar Gardens
    Menston
    LS29 6QA Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    47 Ellar Gardens
    Menston
    LS29 6QA Ilkley
    West Yorkshire
    British43614150001
    GARNETT, Carl Jason
    Goldsworthy Way
    Woolley Grange
    S75 5GT Barnsley
    2
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Goldsworthy Way
    Woolley Grange
    S75 5GT Barnsley
    2
    South Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish163592860001
    JOHNSON, Ian John Fulford
    5 Bronte Villas
    Cross Roads
    BD22 9BW Keighley
    Yorkshire
    Amministratore
    5 Bronte Villas
    Cross Roads
    BD22 9BW Keighley
    Yorkshire
    British1643120005
    MACPHERSON, Ian
    2 Whixley Mews
    Whixley
    YO5 8AR York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Whixley Mews
    Whixley
    YO5 8AR York
    North Yorkshire
    British47264830001
    MARTELL, Patrick Neil
    Norfolk Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HL London
    9
    United Kingdom
    Amministratore
    Norfolk Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HL London
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritish158228830001
    MCAVAN, Katherine
    Belvedere Road
    LS17 8BU Leeds
    13
    United Kingdom
    Amministratore
    Belvedere Road
    LS17 8BU Leeds
    13
    United Kingdom
    United KingdomBritish163593410001
    MCGOLPIN, David
    7 Stonedene Park
    Wetherby
    LS22 7FZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Stonedene Park
    Wetherby
    LS22 7FZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish125431220001
    MCKIE, James
    34 Beech Drive
    Whalley
    BB7 9RA Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    34 Beech Drive
    Whalley
    BB7 9RA Clitheroe
    Lancashire
    British112639490001
    OSBORNE, Paul David
    69 Long Street
    Stoney Stanton
    LE9 4DQ Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    69 Long Street
    Stoney Stanton
    LE9 4DQ Leicester
    Leicestershire
    British46295050001
    RICHELL, Giles
    Copley Lane
    Aberford
    LS25 3ED Leeds
    Lotherton Park Farmhouse
    Amministratore
    Copley Lane
    Aberford
    LS25 3ED Leeds
    Lotherton Park Farmhouse
    EnglandBritish152017460001
    ROBINSON, Malcolm Ernest
    9 Hillfoot Avenue
    LS28 7QN Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Hillfoot Avenue
    LS28 7QN Pudsey
    West Yorkshire
    British32002360001
    SPENCER, John
    Applegarth 2 Town Wells Drive
    Calverley
    LS28 5NN Pudsey
    West Yorkshire
    Amministratore
    Applegarth 2 Town Wells Drive
    Calverley
    LS28 5NN Pudsey
    West Yorkshire
    British1643130002
    STEVENSON, Robert Gary
    262 Cromwell Tower
    EC2Y 8DD London
    Amministratore
    262 Cromwell Tower
    EC2Y 8DD London
    British11278000002
    STREETON, Edward Albert
    5 Sadler Copse
    Adel
    LS16 8NW Leeds
    Amministratore
    5 Sadler Copse
    Adel
    LS16 8NW Leeds
    British11278010002
    SUGDEN, Bernard Brian
    46 Birchdale
    BD16 4SE Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    46 Birchdale
    BD16 4SE Bingley
    West Yorkshire
    British72258860001
    VARNEY, Richard Norman
    Linton House
    North Moor Lane
    YO61 3NB Easingwold
    Yorkshire
    Amministratore
    Linton House
    North Moor Lane
    YO61 3NB Easingwold
    Yorkshire
    United KingdomBritish60136240002

    GLOBAL MP LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 mar 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    In corso
    Breve descrizione
    A. by way of first fixed charge:. (I) all real property;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property;. B. by way of first fixed charge the intellectual property;. "Real property" means all estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the obligor, or in which the obligor has an interest at any time, together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof; and. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof;. "Intellectual property rights" means:. (I) any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests whether registered or unregistered; and. (Ii) the benefit of all applications and rights to use such assets of the company.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Centric SPV1 Limited
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 ott 2013
    Consegnato il 20 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • St Ives Direct Limited
    Transazioni
    • 20 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 08 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • St Ives Direct Limited
    Transazioni
    • 08 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2013
    Consegnato il 28 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 20 ott 1997
    Consegnato il 28 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a one man roland web offset press typ rotoman serial no 27346 together with any part or parts thereof and all additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto all right title and interest in the plant machinery chattels or other equipment described in the schedule to the form 395 together with the benefit of all maintenance agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 lug 1993
    Consegnato il 22 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One used man roland rotoman c 16 page web press serial no. 26780 together with eurotec dryer serial no. 7274 and stobb stacker serial no. 7663. one used man rotoman c 32 page web press:- unit 1: serial no. 27029 including stork contiweb serial no. U1220100 eurotec ii dryer serial no. 7726 and stobb stacker serial no. 7702. unit 2: serial no. 27030 including stork contiweb serial no. U1210100 eurotec dryer serial no. 7634, vits qro sheeter serial no. 9206/0025 and vits blava trimmer serial no. 930148W524.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 13 mag 1992
    Consegnato il 20 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described - see form 395 ref. M410C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 feb 1990
    Consegnato il 02 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 feb 1990
    Consegnato il 26 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from and/or sharpfine limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H site 10 seacroft industrial estate seacroft ring road leeds west yorkshire title no wyk 212191.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 feb 1990
    Consegnato il 26 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from and/or sharpfine limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on n/e side of limewood road. Leeds west yorkshire title no wyk 372221.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 26 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 feb 1990
    Consegnato il 23 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Finans (UK) Limited.
    Transazioni
    • 23 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 15 lug 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mag 1987
    Consegnato il 26 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory no. 1, ring road, seacroft, leeds, west yorkshire t/n wyk 372221.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 03 ago 1984
    Consegnato il 15 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or hunters armley limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 gen 1981
    Consegnato il 20 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold property known as factory site 10 industrial estate seacroft leeds, west yorkshire title no wyk 212191.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 1981Registrazione di un'ipoteca

    GLOBAL MP LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 lug 2014Inizio dell'amministrazione
    05 gen 2018Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0