RYNESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRYNESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00693658
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RYNESS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RYNESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Votec House The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RYNESS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RYNESS ELECTRICAL SUPPLIES LIMITED26 mag 196126 mag 1961

    Quali sono gli ultimi bilanci di RYNESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RYNESS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RYNESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 giu 2014

    Stato del capitale al 04 giu 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Leo Yiu Sing Yu come amministratore in data 04 giu 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Steven Westbrook come segretario in data 04 giu 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Marianne Roberts come amministratore in data 04 giu 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Leo Yu come segretario in data 04 giu 2014

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 13-17 Baron Street London N1 9NH in data 04 giu 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Steven Westbrook come amministratore in data 29 gen 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Nigel John Palmer come amministratore in data 29 gen 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roger David Goddard come amministratore in data 31 ott 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Leo Yu come segretario in data 26 set 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Sean Patrick Mcevoy come segretario in data 30 ago 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di James Edward Deacon Shortridge come amministratore in data 19 lug 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Marianne Roberts come amministratore in data 30 mag 2013

    3 pagineAP01

    Nomina di Leo Yiu Sing Yu come amministratore in data 30 mag 2013

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 30 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2012 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 26 giu 2011

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di RYNESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WESTBROOK, Steven
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    188265410001
    PALMER, Nigel John
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishChief Executive184668410001
    WESTBROOK, Steven
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    EnglandBritishFinancial Director76995140002
    EVENS, Jonathan David Newton
    59 Marsden Road
    AL8 6YH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    59 Marsden Road
    AL8 6YH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishAccountant44344420001
    HOBHOUSE, William Arthur
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    Segretario
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    BritishCompany Director154251580001
    LEVENTON, Lyn Charles
    4 Winchester Place
    Highgate
    N6 5HJ London
    Segretario
    4 Winchester Place
    Highgate
    N6 5HJ London
    British28413490001
    MCEVOY, Sean Patrick
    North End Road
    Fulham Road
    SW6 1NS London
    413
    United Kingdom
    Segretario
    North End Road
    Fulham Road
    SW6 1NS London
    413
    United Kingdom
    Australian92651780003
    YU, Leo
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Vo-Tec Centre
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    England
    181632550001
    BRAND, Giles Robert
    131 Fentiman Road
    SW8 1JZ London
    Greater London
    Amministratore
    131 Fentiman Road
    SW8 1JZ London
    Greater London
    EnglandBritishExecutive112853610001
    EVENS, Jonathan David Newton
    59 Marsden Road
    AL8 6YH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    59 Marsden Road
    AL8 6YH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishAccountant44344420001
    FEATHERSTONE, Lynne Choona
    20 North Grove
    Highgate
    N6 4SL London
    Amministratore
    20 North Grove
    Highgate
    N6 4SL London
    BritishDirector28413500002
    GODDARD, Roger David
    Tatton Street
    WA16 6AY Knutsford
    Edmundson House
    Cheshire
    Amministratore
    Tatton Street
    WA16 6AY Knutsford
    Edmundson House
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector83553400001
    HOBHOUSE, William Arthur
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Church Lane
    WD3 6HJ Sarratt
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director154251580001
    JORDAN, Geoffrey Arthur
    Palo Alto
    Stortford Road
    CM22 7DL Hatfield Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Palo Alto
    Stortford Road
    CM22 7DL Hatfield Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director141396540001
    LEVENTON, Lyn Charles
    4 Winchester Place
    Highgate
    N6 5HJ London
    Amministratore
    4 Winchester Place
    Highgate
    N6 5HJ London
    BritishDirector28413490001
    LINDSAY, Andrew
    22 Carthew Villas
    W6 0BS London
    Amministratore
    22 Carthew Villas
    W6 0BS London
    United KingdomBritishDirector100461230003
    MCEVOY, Sean Patrick
    Coxs Gardens
    CM23 3GX Bishop's Stortford
    9
    Hertfordshire
    Amministratore
    Coxs Gardens
    CM23 3GX Bishop's Stortford
    9
    Hertfordshire
    United KingdomAustralianFinance Director92651780003
    ROBERTS, Marianne
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishOperations Director178879660001
    ROSE, Richard Sidney
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    Amministratore
    Ivonbrook
    27 Totteridge Village
    N20 8PN London
    EnglandBritishChief Executive Officer20113670001
    RYNESS-HIRSCH, Adele Lois
    2 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Amministratore
    2 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    BritishDirector39172840001
    RYNESS-HIRSCH, Adele Lois
    2 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    Amministratore
    2 Southwood Lawn Road
    Highgate
    N6 5SF London
    BritishDirector39172840001
    SHORTRIDGE, James Edward Deacon
    North End Road
    Fulham Road
    SW6 1NS London
    413
    United Kingdom
    Amministratore
    North End Road
    Fulham Road
    SW6 1NS London
    413
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector112775470005
    WILLIS, Steven
    137 Weavens Way
    Elm Village
    N1 London
    Amministratore
    137 Weavens Way
    Elm Village
    N1 London
    BritishDirector15373960001
    YU, Leo Yiu Sing
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hambridge Lane
    RG14 5TN Newbury
    Votec House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone178879240001

    RYNESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 apr 2010
    Consegnato il 07 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 apr 2010
    Consegnato il 06 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Epic Investments LLP (Epic)
    Transazioni
    • 06 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 25 apr 2010
    Consegnato il 01 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Giles Robert Brand
    Transazioni
    • 01 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 08 ago 2008
    Consegnato il 15 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Epic Investments LLP
    Transazioni
    • 15 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment in security of life policy
    Creato il 08 ago 2008
    Consegnato il 12 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    St andrew life assurance PLC policy no: ASSH044757 life assured: james shortridge sum assured: £1,000,000 date of policy: 01/08/2006 all of its rights in relation to the policy.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and ryness buyerco limited (the borrower) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Epic Investments LLP
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 08 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 15 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 14 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the noteholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Equity Partnership Investment Company PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1985
    Consegnato il 14 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    34A & 34 to 41 white lion street and 1 & 2 penton grove, finsbury.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0